HENDERSON PHARMACY LIMITED

HENDERSON PHARMACY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHENDERSON PHARMACY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01390581
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    P & CE HENDERSON LIMITED25 set 197825 set 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2013

    Stato del capitale al 03 lug 2013

    • Capitale: GBP 180
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Muller come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Patricia Kennerley come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Aylward come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Muller come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Christopher James Giles come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Segretario
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401690001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    HENDERSON, Cyraine Elizabeth
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British16015100002
    HENDERSON, Susan
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    British43148360003
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Amministratore
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritish59741430002
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    HENDERSON, Cyraine Elizabeth
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British16015100002
    HENDERSON, Philip
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish16015110003
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Amministratore
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002

    HENDERSON PHARMACY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of goodwill
    Creato il 09 mar 1999
    Consegnato il 23 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns all the beneficial interest and goodwill of the company in the business(es) carried out or to be carried on by the company at (a) the central pharmacy, 1 cattle market, hexham, northumberland NE46 1NJ (b) abbey chemists 4 hencotes hexham northumberland NE46 2EJ (c) pattinson pharmacy 77 front street prudhoe northumberland NE42 5PU. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37/39 queen street amble northumberland t/no.ND99742. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 03 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 dean terrace ryton tyne and wear NE40 3HQ t/no;-TY281871. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 13 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Brevi particolari
    F/H k/a 48/48A front street prudhoe northumberland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 13 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a bridge house 5 & 6 station road bedlington t/n nd 30312.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 13 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 286 & 288 chillingham road, heaton, newcastle upon tyne. T/n TY163202.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 13 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Brevi particolari
    F/H & l/h property present & future fixed charge goodwill, uncalled capital,stocks floating charge and. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H all that ground floor shop at premises k/a 6 in the precinct hadston in the county of northumberland & the proceed of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal mortgage
    Creato il 29 set 1989
    Consegnato il 18 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    286/288 chillingham road heaton, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1989
    Consegnato il 16 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold, bridge house, bedlington, northumberland. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 mag 1986
    Consegnato il 21 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 7/7A the broadway darras hall porteland newcastle upon tyne and tyne and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 mag 1986
    Consegnato il 21 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and the proceeds of sle thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 286/288 chillingham road, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 22 ott 1982
    Consegnato il 22 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as 93 95 and 97 park view whitley bay, tyne and wear and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0