ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01393272 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Rose Court 2 Southwark Bridge Road SE1 9HS London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ADDISON DESIGN COMPANY LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| ADDISON DESIGN LIMITED | 10 ott 1978 | 10 ott 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alexander James Spark come amministratore in data 28 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 04 mag 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Tom Oakley Robinson come amministratore in data 20 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 Brewhouse Yard London EC1V 4DG England a Rose Court 2 Southwark Bridge Road London SE1 9HS in data 10 gen 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2020 al 30 giu 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Wpp Toronto Ltd come persona con controllo significativo il 20 nov 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Wpp Group (Nominees) Limited il 26 nov 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 26 pagine | AA | ||||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 49 Southwark Bridge Road London SE1 9HH a 6 Brewhouse Yard London EC1V 4DG in data 04 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Heligman come amministratore in data 12 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Segretario | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House England |
| 80143770001 | ||||||||||
| PRIOR, James Edward Cairns | Amministratore | 2 Southwark Bridge Road SE1 9HS London Rose Court England | England | British | 199894090001 | |||||||||
| HORNER, Christopher John | Segretario | Rugby Road BN1 6ED Brighton 64 East Sussex | British | 109247280001 | ||||||||||
| KING, Matthew | Segretario | 20 Pembury Road TN9 2HX Tonbridge Kent | British | 35000540005 | ||||||||||
| ROBERTSON, Wendy | Segretario | 140 Roslyn Road N15 5JJ London | British | 88285400001 | ||||||||||
| ROBINSON, Clare | Segretario | 24 Heddon Court Avenue EN4 9NE Barnet Hertfordshire | British | 17397270004 | ||||||||||
| ANDERSON, Quentin Michael Cordue | Amministratore | Witham House Witham Friary BA11 5HD Frome Somerset | British | 58070490003 | ||||||||||
| BEST, Gary | Amministratore | 61 Hurstwood ME5 0XH Chatham Kent | British | 70270530004 | ||||||||||
| BROCK, James | Amministratore | 5 Amesbury Road BR1 2QJ Bromley Kent | British | 95744440002 | ||||||||||
| BYROM, Roger | Amministratore | 58 Walnut Tree Walk SE11 6DN London | British | 15758830001 | ||||||||||
| CHODEL, Peter | Amministratore | 20 Finsen Road SE5 9AX London | British | 69370540001 | ||||||||||
| DOW, Robin Charles | Amministratore | Inveresk Lodge Inveresk Village EH21 7TE East Lothian | Scotland | British | 15758850002 | |||||||||
| EMERY, Philippa | Amministratore | 27 Lower Common South SW15 1BP London | British | 40210820001 | ||||||||||
| HELIGMAN, Matthew | Amministratore | Southwark Bridge Road SE1 9HH London 49 | England | British | 202761900001 | |||||||||
| HILL, Mark Eldon | Amministratore | Southwark Bridge Road SE1 9HH London 49 England | United Kingdom | British | 28028120005 | |||||||||
| HORJUS, Robert Charles | Amministratore | Southwark Bridge Road SE1 9HH London 49 England | United States | American | 180723380001 | |||||||||
| HORNER, Christopher John | Amministratore | Rugby Road BN1 6ED Brighton 64 East Sussex | British | 109247280001 | ||||||||||
| HUTCHINS, Miles | Amministratore | 16 Well Walk Hampstead NW3 1LD London | United Kingdom | British | 15758860003 | |||||||||
| JEFFERSON, Guy | Amministratore | South Western Road TW1 1LG Twickenham 47 Middlesex United Kingdom | British | 109247360002 | ||||||||||
| KING, Matthew | Amministratore | 20 Pembury Road TN9 2HX Tonbridge Kent | British | 35000540005 | ||||||||||
| KRARUP, William Nicholas Christian | Amministratore | Honey Hill Farm NN6 6NL Elkington Northamptonshire | United Kingdom | British | 21199360007 | |||||||||
| LAKE, Simon Charles | Amministratore | 1 Manor Cottages The Street TN33 0QG Sedlescombe East Sussex | England | British | 109785980001 | |||||||||
| LANGSFORD, Paul Anthony | Amministratore | 160 Nether Street West Finchley N3 1PE London | British | 41947430001 | ||||||||||
| LOVE, Lois | Amministratore | 90 Albert Street NW1 7NE London | British | 36720690002 | ||||||||||
| MURDOCH, Shelley Ann | Amministratore | Flat 2 1 Cardigan Road TW10 6BJ Richmond Surrey | British | 45785200002 | ||||||||||
| PAPADAKIS, Alexios | Amministratore | 2 Cathedral Street London SE1 9DE | United Kingdom | Greek South African | 138561460001 | |||||||||
| PARKER, Kate Elizabeth | Amministratore | 28 Gerrard Road Islington N1 8BA London | British | 49886700001 | ||||||||||
| PERRY, Keith | Amministratore | 46a Cranley Gardens Palmers Green N13 4LS London | British | 76537990001 | ||||||||||
| PRIOR, James Edward Cairns | Amministratore | Southwark Bridge Road SE1 9HH London 49 | England | British | 199894090001 | |||||||||
| ROBINSON, Clare | Amministratore | 96 Stanley Road N11 2LG London | British | 17397270002 | ||||||||||
| ROBINSON, Tom Oakley | Amministratore | Summerfield 67 Lewes Road BN6 8TY Ditchling East Sussex | England | British | 68582270004 | |||||||||
| SKOGSTAD, Leif | Amministratore | 14 Bramley Way KT21 1QU Ashtead Surrey | British | 83527150001 | ||||||||||
| SLATER, David Alan | Amministratore | 38 Belleville Road SW11 6QT London | British | 33092010002 | ||||||||||
| SLATER, Michael James | Amministratore | 24 Prospect Place Wapping Wall Wapping E1 9TJ London | British | 38634460003 | ||||||||||
| SMITH, Stephen Albert | Amministratore | 17 Ladbroke Square W11 3NA London | United Kingdom | British | 15758840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wpp Toronto Ltd | 06 apr 2016 | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ADDISON CORPORATE MARKETING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 13 lug 1995 Consegnato il 20 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 31 ago 1989 Consegnato il 08 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company being addison worldwide limited. To the chargee. Under a loan agreement dated 14TH june '89 and delivered on 28TH july '89. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 31 ago 1989 Consegnato il 08 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company being addison worldwide limited. To the chargee. Under a loan agreement dated 14TH june 1989 and delivered on 28TH july 1989 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0