L H GROUP SERVICES LIMITED

L H GROUP SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàL H GROUP SERVICES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01394005
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di L H GROUP SERVICES LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    L.H. PLANT (ENG. SERVICES) LIMITED13 ott 197813 ott 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 set 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 set 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al08 set 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 nov 2024

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 nov 2023

    10 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    9 pagineLIQ10

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Howard House Graycar Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent Staffordshire DE13 8EN

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Howard House Graycar Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent Staffordshire DE13 8EN

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Howard House Graycar Business Park, Barton Turn Barton Under Needwood Burton-on-Trent Staffordshire DE13 8EN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 15 nov 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 nov 2022

    LRESSP

    Nomina di Nichola Bramley come amministratore in data 08 ott 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Michael Seitz come amministratore in data 03 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Garry John Mowbray come amministratore in data 03 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Thomas Derbyshire come amministratore in data 03 ott 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Garry John Mowbray come amministratore in data 24 mag 2022

    2 pagineAP01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve accounts 28/09/2021
    RES13

    legacy

    37 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Erin Boyts Quinn come amministratore in data 19 lug 2021

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEITZ, David Michael
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    285411300001
    BRAMLEY, Nichola
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandEnglishSenior Director Finance Transit Regional Service301423930001
    CALVER, Robert Edward
    55 Efflinch Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EU Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    55 Efflinch Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EU Burton On Trent
    Staffordshire
    British1477350001
    ISAAC, Michael James
    The Green
    Findern
    DE65 6AA Derby
    19
    England
    Segretario
    The Green
    Findern
    DE65 6AA Derby
    19
    England
    British106397180001
    QUINN, Erin Boyts
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Segretario
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    277932950001
    BEASLEY, David
    22 Weavers Croft
    Rawfolds
    BD19 5NE Cleckheaton
    Amministratore
    22 Weavers Croft
    Rawfolds
    BD19 5NE Cleckheaton
    BritishSales Manager31599600002
    DERBYSHIRE, Andrew Thomas
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector263090480001
    HILDUM, Keith Patrick
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanVp Treasurer134557260001
    ISAAC, Michael James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant106397180002
    ISAAC, Michael James
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant106397180001
    LEE, Carol Ann
    Statfold Barn Farm
    Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Statfold Barn Farm
    Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector1477370001
    LEE, Graham Ivan
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector47973700001
    LEE, Graham
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector1477360001
    MEYER, David James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanGroup Executive176950830001
    MOWBRAY, Garry John
    Hexthorpe Road
    DN4 0BF Doncaster
    Doncaster Works,
    England
    Amministratore
    Hexthorpe Road
    DN4 0BF Doncaster
    Doncaster Works,
    England
    EnglandEnglishVice President Regional Services Uk218537160001
    QUINN, Erin Boyts
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    United StatesAmericanLawyer278775590001
    SEITZ, David Michael
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    United StatesAmericanLawyer188480930001
    WALLER, David
    Southay
    BA13 4RT Bratton
    20
    Wiltshire
    Amministratore
    Southay
    BA13 4RT Bratton
    20
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector114193310001
    WEATHERALL, Christopher John
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishManaging Director172779280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di L H GROUP SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
    Air Brake Avenue
    Wilmerding
    1001
    Pennsylvania 15148
    United States
    06 apr 2016
    Air Brake Avenue
    Wilmerding
    1001
    Pennsylvania 15148
    United States
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione7209033
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    L H GROUP SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 apr 2015
    Consegnato il 25 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 ago 2010
    Consegnato il 19 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 29 gen 2007
    Consegnato il 02 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    400T universal wheelpress supplied by cem international per invoice s/n S003743, wheelpres (built by lh group services in 2006), HM4OU horizontal bearing balancing machine for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 03 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £158,074.41 together with interest and charges theron due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A first fixed charge over, universal wheel press and associated tooling, serial number: 003743 and HM40U horizontal hard bearing balancing machine, serial number: RMHF0205.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 03 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture by the company and J. & D. gears limited and l h group holdings limited
    Creato il 28 ago 2001
    Consegnato il 05 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1996
    Consegnato il 25 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of bond street burton upon trent staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1996
    Consegnato il 25 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south east side of green street burton on trent staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee debenture
    Creato il 24 mar 1986
    Consegnato il 02 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 giu 1980
    Consegnato il 24 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 24 giu 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    L H GROUP SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 nov 2022Inizio della liquidazione
    03 nov 2022Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Peter Dempster
    Ernst & Young Llp, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Ernst & Young Llp, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0