DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01394433 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DST INNOVIS INTERNATIONAL PLC | 08 ott 1999 | 08 ott 1999 |
| CUSTIMA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 12 dic 1994 | 12 dic 1994 |
| CREATIVE COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 17 ott 1978 | 17 ott 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Olswang Cosec Limited come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Joseph Saeger il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Olswang Cosec Limited il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2007 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 11 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEGER, Michael Joseph | Amministratore | 1118 Spring Orchard Dr O'Fallon Mo 63368 Usa | Usa | American | 132979460001 | |||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Segretario | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | British | 58166010001 | ||||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Segretario | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | British | 58166010001 | ||||||||||
| LACEY, Oliver Blomfield | Segretario | The White Cottage Norcott Hall HP4 1LB Northchurch Hertfordshire | British | 76927620002 | ||||||||||
| REEDER, Tracy | Segretario | 12 Partridge Road The Avenue TW12 3SB Hampton Middlesex | British | 67016660002 | ||||||||||
| SCOTT, Roderick Frank | Segretario | 89 Cottenham Park Road Wimbledon SW20 0DS London | British | 3758800003 | ||||||||||
| STEELE, Anne | Segretario | 25 The Avenue Chiswick W4 1HA London | British | 77624110001 | ||||||||||
| MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 30 Aylesbury Street EC1R 0ER London | 32643220001 | |||||||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Segretario | High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor, 90 United Kingdom |
| 83864780002 | ||||||||||
| REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Minerva House 5 Montague Close SE1 9BB London | 80748880001 | |||||||||||
| CAPAL, Barry | Amministratore | 30 Church Lane IG10 1PD Loughton Essex | British | 13121900001 | ||||||||||
| CATER, Anthony Ralph | Amministratore | 168 Lodge Lane RM16 2TS Grays Essex | England | British | 58166010001 | |||||||||
| COPELLO, Philippe Pierre Alain | Amministratore | 96 Rue Du President Wilson 92300 Levallois France | French | 37755670001 | ||||||||||
| DARBY, Peter William | Amministratore | 20 Herdson Road CT20 2PB Folkestone Kent | British | 42644160001 | ||||||||||
| DELL, Susan Ursula | Amministratore | 15118 De La Cruz Rancho Murieta Ca 95683 Usa | Usa | 73814290001 | ||||||||||
| EWAN, James Gordon | Amministratore | 16 The Winery Regents Bridge Gardens Rita Road SW8 1RJ London | British | 46387310001 | ||||||||||
| FRAMPTON, Michael David | Amministratore | 5670 Stone Haven Court CA 95746 Granite Bay California Usa | British | 54352500003 | ||||||||||
| FRANK, Peter Henry Edmund | Amministratore | 2 Butt Lane Allesley CV5 9EU Coventry West Midlands | British | 29010440001 | ||||||||||
| GASCHIGNARD, Pierre Etienne | Amministratore | 2 Petite Rue De Refuge FOREIGN Versailles 78000 France | French | 13121920002 | ||||||||||
| GRACIE, Anita Elizabeth | Amministratore | 28 Windsor Road Holloway N7 6JG London | United Kingdom | British | 57619410001 | |||||||||
| HARTNELL, Nigel Raymond | Amministratore | 7 North Avenue Ealing W13 8AP London | England | British | 13121930001 | |||||||||
| HATCH, Brett | Amministratore | 26 Pitman Hill Road St Charles Missouri 63304 Usa | American | 106338680001 | ||||||||||
| HORGAN, John J | Amministratore | 319 Tulip Drive FOREIGN St Louis Missouri 63119 Usa | United States | 106338760001 | ||||||||||
| HORGAN, John J | Amministratore | 319 Tulip Drive FOREIGN St Louis Missouri 63119 Usa | United States | 106338760001 | ||||||||||
| KLEIN, Zaida Avila | Amministratore | 9555 Golf Course Lane Elk Grove Ca 95758 Usa | Us Citizen | 82335640003 | ||||||||||
| KNIGHT, Jane Elizabeth | Amministratore | 1 Rectory Lane ME16 9BE Maidstone Kent | England | British | 106193590001 | |||||||||
| MCGRAIL, Michael | Amministratore | 86 Sigrist Square KT2 6JY Kingston Upon Thames Surrey | British | 24508960002 | ||||||||||
| MCGUIRK, Kieran | Amministratore | 13 The Park AL1 4SE St Albans Hertfordshire | England | British | 167992250001 | |||||||||
| MUIR, George Watson | Amministratore | 32 Hestercombe Avenue SW6 5LG London | United Kingdom | British | 12446270001 | |||||||||
| NAULT, Peter J | Amministratore | 10518 Kenlauren Terrace Charlotte North Carolina 28210 Usa | Us Citizen | 82335670001 | ||||||||||
| PATEL, Kiran Dayalji | Amministratore | 11 St Johns Terrace Road Earlswood RH1 6HS Redhill Surrey | British | 77621760001 | ||||||||||
| POWELL, Patricia Margaret | Amministratore | 23 Mansard Close RM12 4HS Hornchurch Essex | British | 44922510001 | ||||||||||
| RIDDLE, Richard John Smillie | Amministratore | 25 Connel Road Blairgowrie Randburg FOREIGN South Africa | British | 42052310002 | ||||||||||
| TEAGUE, David John | Amministratore | 107 Queens Road TW11 0LZ Teddington Woodborough House Middlesex Uk | United Kingdom | British | 144848790001 | |||||||||
| WHITTAKER, Martyn Richard | Amministratore | 7 Childsbridge Way Seal TN15 0DG Sevenoaks Kent | British | 50406940002 |
DST INNOVIS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 16 lug 1996 Consegnato il 24 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balances | Creato il 25 mag 1993 Consegnato il 09 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 25/5/93 in favour of deutsche gesellschaft fur technische zusannenarbeit (gtz) gmbh for £9200 | |
Brevi particolari The sum of £9200 together with interest held by national westminster bank PLC on an account no. 95313710 and designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0