01397101 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01397101 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01397101
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01397101 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova 01397101 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 01397101 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POWER LIFT ENGINEERING LIMITED31 ott 197831 ott 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01397101 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per 01397101 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed U.K. lift company LIMITED(the)\certificate issued on 07/04/17
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2015

    Stato del capitale al 29 giu 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2014

    Stato del capitale al 01 lug 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Kone Plc Global House Station Place Fox Lane North Chertsey Surrey ME2 3SW

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Rachel Loaring come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Gerard Keith Loty come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Nomina di Miss Rachel Victoria Loaring come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Simon White come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jeffery Mannooch come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di 01397101 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITE, Simon
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    Segretario
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    162874650001
    LOTY, Gerard Keith
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    EnglandAustralianAccountant157382530001
    KONE PUBLIC LIMITED COMPANY
    Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Global House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Global House
    Surrey
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1372978
    154331930001
    LOARING, Rachel Victoria
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    Segretario
    Global House
    Station Place Fox Lane North
    KT16 9HW Chertsey
    Surrey
    162874800001
    MANNOOCH, Jeffery Richard
    21 Beaufort Road
    Strood
    ME2 3SW Rochester
    Kent
    Segretario
    21 Beaufort Road
    Strood
    ME2 3SW Rochester
    Kent
    BritishCompany Secretary18577660001
    PIGGOTT, Trevor
    The Old School House
    Ivinghoe Aston
    LU7 9DP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Segretario
    The Old School House
    Ivinghoe Aston
    LU7 9DP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishDirector4628800002
    SUNTER, John Calvert
    Park Farm
    Coton
    NN6 8RG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Park Farm
    Coton
    NN6 8RG Northampton
    Northamptonshire
    BritishAccountant35398460002
    DAY, Mark
    44 Kings Road
    RH13 5PR Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    44 Kings Road
    RH13 5PR Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishFinance Director15646810002
    HOLDEN, Clive Morton Butler
    1 The Birches
    Beechwood Park
    HP3 0LJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Birches
    Beechwood Park
    HP3 0LJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishManager15118550002
    HOLDEN, Clive Morton Butler
    1 The Birches
    Beechwood Park
    HP3 0LJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Birches
    Beechwood Park
    HP3 0LJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector15118550002
    MCDONALD, David Andrew
    33a Park Road
    LU5 6AB Toddington
    Bedfordshire
    Amministratore
    33a Park Road
    LU5 6AB Toddington
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director120728010001
    PIGGOTT, Trevor
    Five Acres
    Little Billington
    LU7 9BP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    Five Acres
    Little Billington
    LU7 9BP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector4628800004
    PITHER, Gary John
    3 Russell's House, Greenbank Road
    WD17 4RJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Russell's House, Greenbank Road
    WD17 4RJ Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSales Director11591620005
    SUNTER, John Calvert
    Park Farm
    Coton
    NN6 8RG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Park Farm
    Coton
    NN6 8RG Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishAccountant35398460002

    01397101 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Collateral debenture
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 24 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 24 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 set 1990
    Consegnato il 17 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or haventrips limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 04 set 1990
    Consegnato il 10 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from haventrips limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Stock-in-trade, work-in-progress pre-payments & investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 10 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 01 feb 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ago 1990Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 giu 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 apr 1985
    Consegnato il 15 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 sandown road watford hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 feb 1982
    Consegnato il 11 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed and further deeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 11 mag 1981
    Consegnato il 28 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed & further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0