NCN 9 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNCN 9 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01399139
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NCN 9 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NCN 9 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NCN 9 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WORLD CLASS LEARNING LIMITED07 ott 199707 ott 1997
    NOVARA LIMITED31 dic 198131 dic 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di NCN 9 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NCN 9 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NCN 9 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 02 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2014

    Stato del capitale al 03 set 2014

    • Capitale: GBP 193,100
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ago 2013

    Stato del capitale al 19 ago 2013

    • Capitale: GBP 193,100
    SH01

    Cessazione della carica di Ivan Bolton come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2012

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed world class learning LIMITED\certificate issued on 08/08/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name08 ago 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 giu 2012

    RES15
    change-of-name08 ago 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 27 lug 2012

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 27/06/2012
    RES13

    Nomina di Mark Ashcroft come segretario

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 01 apr 2011

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Ivan Bolton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 18 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Credit agreement 08/02/2011
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH* in data 21 gen 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 apr 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Dr Ivan Joseph Bolton il 18 ago 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Christopher Hinton come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Timothy John Kowalski come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di NCN 9 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165369240001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish15967010001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    British14333000007
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Segretario
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    British78151560001
    PIGGOTT, Richard Courtney
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    British112085820001
    TAYLOR, Frank Brownrigg
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    British57228790001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    CHAPMAN, Richard Jonathan Edward
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    British14871980001
    CHERRY, Anthony Peter
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    285 Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0RR Beverley
    North Humberside
    British27289350001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Amministratore
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    FORGHAM, John Anthony
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    Amministratore
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    British33338170001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Amministratore
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Amministratore
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Amministratore
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    MACEY, David Charles
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish91745430001
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Amministratore
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    British81630780001
    WOOD, Nicholas
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    27 Asher Street
    Felling
    NE10 0AY Gateshead
    Tyne & Wear
    British15885680001
    WOOD, Stephen
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    British33636730001

    NCN 9 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental security agreement
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns an agreement being any of the existing facility agreement the new super senior credit agreement the revolving credit agreement and the ancillary facility agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession to the security agreement
    Creato il 16 lug 2010
    Consegnato il 29 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 29 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Single debenture
    Creato il 15 nov 1990
    Consegnato il 03 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 ago 1989
    Consegnato il 24 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    FR60 injection moulding machine number 117816 FR60 injection moulding machine number 117723 FR60 injection moulding machine number 117813 KM60 injection moulding machine number 60077 MS120 injection moulding machine number 70741.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    Corporate mortgage
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 03 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 3.2.87
    Brevi particolari
    F.R. 60 injection moulding machine serial no 117805 two injection moulding tools for 9CM petri dishes manufactures by exfaleoha as per orrembley jrawing number 1.899/900-10-86.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Corporate mortgage
    Creato il 02 nov 1988
    Consegnato il 10 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 4TH jan 1988
    Brevi particolari
    Bekum blow moulding machine bae - 1 serial no. 27712689 (see form 395-ref: M218- for details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Corporate mortgage
    Creato il 15 dic 1983
    Consegnato il 30 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 16 sept. 1982
    Brevi particolari
    One blav moulding machine type UK 1-0,7. one piovan chiller model rcn 120/10 serial no 01300 (see M17 for details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 ott 1982
    Consegnato il 28 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The goods (herinafter descreibed) the benefit of all contracts, conditionswarranties and agreements all logbooks maintenance records record books and other documents relating to the goods any moneys payable to the company for orin connection with a sale or proposed sale of of any of the goods. 1-Off model s-12 injection bion moulding machine 1-off chiller, 1-off product conveyor(lessana supplied) as described in contract no b 600305 dated 14/09/82.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 25 set 1981
    Consegnato il 05 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £30,000 and other monies due under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Plant & machhinery at unit 9 phase 111 algernon industrial estate shiremoor tyne & wear. Floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Tyne and Wear County Council
    Transazioni
    • 05 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 22 gen 1981
    Consegnato il 29 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capitals all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0