HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED

HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOSEASONS HOLIDAYS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01400552
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trinity House
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE HOSEASONS GROUP HOLDINGS LIMITED30 giu 201130 giu 2011
    THE HOSEASONS GROUP LIMITED09 giu 201009 giu 2010
    HOLIDAY COTTAGES GROUP LIMITED15 feb 199615 feb 1996
    COUNTRY HOLIDAYS LIMITED27 feb 198727 feb 1987
    COUNTRY HOLIDAYS (SKIPTON) LIMITED17 nov 197817 nov 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 feb 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 feb 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al08 feb 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2024

    17 pagineAA

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    116 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione della carica di Garry Clark Adam come amministratore in data 30 lug 2025

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW England a Trinity House Riverside Road Lowestoft NR33 0SW in data 08 lug 2025

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunway House Raglan Road Lowestoft NR32 2LW England a Trinity House Waveney Drive Lowestoft NR33 0SW in data 01 lug 2025

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Triangle 5 - 17 Hammersmith Grove Hammersmith London W6 0LG England a Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2025 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew John Price come amministratore in data 07 feb 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henrik Vilhelm Kjellberg come amministratore in data 07 feb 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023

    18 pagineAA

    legacy

    118 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 mar 2024

    • Capitale: GBP 17,039,334
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Awaze Limited come persona con controllo significativo il 29 set 2023

    2 paginePSC02

    Cessazione di Compass Bidco Ii Limited come persona con controllo significativo il 29 set 2023

    1 paginePSC07

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2022

    22 pagineAAMD

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    22 pagineAA

    Stato del capitale al 19 apr 2023

    • Capitale: GBP 15,030,010
    5 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRICE, Matthew John
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    Trinity House
    England
    Amministratore
    Riverside Road
    NR33 0SW Lowestoft
    Trinity House
    England
    United KingdomBritish242597980001
    ALDCROFT, Christopher Stuart
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    Segretario
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    British63420360001
    BANKES, Henry Francis John
    5-17 Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    United Kingdom
    Segretario
    5-17 Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    United Kingdom
    British102155820002
    BANKES, Henry Francis John
    67 Blenheim Terrace
    NW8 0EJ London
    Segretario
    67 Blenheim Terrace
    NW8 0EJ London
    British102155820001
    BANNISTER, Christopher Keith
    535 Watford Road
    Chiswell Green
    AL2 3DU St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    535 Watford Road
    Chiswell Green
    AL2 3DU St. Albans
    Hertfordshire
    British63470060001
    GIDLEY, Peter Robert
    Post Cottage
    12 Wakerley Road
    NN17 3AH Harringworth
    Northamptonshire
    Segretario
    Post Cottage
    12 Wakerley Road
    NN17 3AH Harringworth
    Northamptonshire
    British36431140002
    GOSTLING, Bryan Richard
    18 Bircham Road
    Reepham
    NR10 4NQ Norwich
    Norfolk
    Segretario
    18 Bircham Road
    Reepham
    NR10 4NQ Norwich
    Norfolk
    British51954690001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    9 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    Segretario
    9 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    British67893790001
    NASTA, Marius Ion
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Segretario
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Belgian50087790005
    NASTA, Marius Ion
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Segretario
    44 Wynnstay Gardens
    Allen Street
    W8 6UT London
    Belgian50087790005
    PARKINSON, Ian
    17 Fallowfield Avenue
    LA12 7XD Ulverston
    Cumbria
    Segretario
    17 Fallowfield Avenue
    LA12 7XD Ulverston
    Cumbria
    British72230040001
    PARRY, John Martin
    4 The Coppice
    Middleton
    LS29 0EZ Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    4 The Coppice
    Middleton
    LS29 0EZ Ilkley
    West Yorkshire
    British91431530001
    ADAM, Garry Clark
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    Amministratore
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    EnglandBritish150460730002
    ADAM, Garry
    The Pickerings
    Brixworth
    NN6 9XA Northampton
    12
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Pickerings
    Brixworth
    NN6 9XA Northampton
    12
    Northamptonshire
    United Kingdom
    British135966620001
    AILLES, Ian Simon
    Beaumont Avenue
    AL1 4TP St. Albans
    84
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beaumont Avenue
    AL1 4TP St. Albans
    84
    Hertfordshire
    EnglandBritish128695490001
    ALDCROFT, Christopher Stuart
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    2 Thorn Lea Close
    BL1 5BE Bolton
    Lancashire
    British63420360001
    ALLAN, Leslie Stewart
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    Amministratore
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    British1704690001
    BACK, Jonathan David
    Darland Hall Farm House
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    Darland Hall Farm House
    Darland Lane, Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Clwyd
    WalesBritish113705840001
    BANKES, Henry Francis John
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    Amministratore
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    United KingdomBritish102155820004
    BARTON, Eric Anthony
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Glendale 9 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish1323220001
    BRENNAN, William Joseph
    28 Priory Road
    Kew
    TW9 3DH London
    Amministratore
    28 Priory Road
    Kew
    TW9 3DH London
    United States97989400002
    BRETT, Paul
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Amministratore
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    United KingdomBritish68902240001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish71153170002
    COWLEY, Geoffrey John
    Barnoldswick
    BB94 0AA Earby
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Barnoldswick
    BB94 0AA Earby
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish45049290004
    DEUTSCH, Franz Markus
    Academy Gardens Apartment 21
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QQ London
    Amministratore
    Academy Gardens Apartment 21
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QQ London
    British78643290004
    FORBES, Scott Edward
    Flat 1
    44 Cranley Gardens
    SW7 3DE London
    Amministratore
    Flat 1
    44 Cranley Gardens
    SW7 3DE London
    EnglandBritish106973270001
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Amministratore
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    FRITH, Michael
    Upper Bennetts
    Penn Road Knotty Green
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Upper Bennetts
    Penn Road Knotty Green
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British16669400001
    GIAMALVA, Frank Peter
    46 Cheval Place
    SW7 1ER London
    Amministratore
    46 Cheval Place
    SW7 1ER London
    American104404420003
    GIDLEY, Peter Robert
    Copy Nook
    Lothersdale
    BD20 8EQ Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Copy Nook
    Lothersdale
    BD20 8EQ Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish36431140004
    HUGHES, Andrew Lawrence
    7 Brooke Close
    LE15 6GD Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    7 Brooke Close
    LE15 6GD Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish109749210001
    HUSSAIN, Sadat
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Earby
    BB94 0AA Barnoldswick
    Spring Mill
    Lancashire
    England
    EnglandBritish176593840001
    KJELLBERG, Henrik Vilhelm
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    Amministratore
    Raglan Road
    NR32 2LW Lowestoft
    Sunway House
    England
    United KingdomSwedish244090880001
    LEE, John Robert Louis, Lord Lee Of Trafford
    49 Langham Road
    Bowdon
    WA14 3NS Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    49 Langham Road
    Bowdon
    WA14 3NS Altrincham
    Cheshire
    British2950910001
    LEPPARD, Martin Neal
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish155863600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Awaze Limited
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    England
    29 set 2023
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione11184954
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    09 mag 2018
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11188307
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    England
    06 apr 2016
    Hammersmith Grove
    W6 0LG London
    The Triangle
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07149144
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0