MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED

MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01403501
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Level 12 The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TWO FLAGS EXCELLENCE LIMITED15 giu 199915 giu 1999
    TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED05 set 199605 set 1996
    AMR TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED19 apr 199419 apr 1994
    TWO FLAGS LIMITED04 dic 197804 dic 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    17 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    16 pagineLIQ10

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Stephanie Alison Pound il 23 mag 2023

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 mar 2023

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Mark Williams il 19 lug 2021

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 dic 2020 al 31 mar 2021

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Jeremy Mark Williams come amministratore in data 07 apr 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Maclellan International Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT a Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 02 dic 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Richard John Butler come amministratore in data 30 nov 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Katherine Woods come amministratore in data 30 nov 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mitie Company Secretarial Services Limited come segretario in data 30 nov 2020

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Stephanie Alison Pound come segretario in data 30 nov 2020

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Stephanie Alison Pound il 15 mar 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Segretario
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5228356
    148474450001
    POUND, Stephanie Alison
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Amministratore
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish213930870003
    WILLIAMS, Jeremy Mark
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Amministratore
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish280831530001
    WOODS, Katherine
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Amministratore
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    United KingdomBritish237400250001
    BLACKBURN, Peter Edward
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    Segretario
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    British75964810001
    COOPER, Philip William
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    British9839440001
    FERNLEY, Renee Amy Margaret
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Segretario
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221020001
    GREEN, Kevin Hartley
    15 Manor Farm Close
    Barton Le Clay
    MK45 4TB Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    15 Manor Farm Close
    Barton Le Clay
    MK45 4TB Bedford
    Bedfordshire
    British72862750001
    MARLETT, Charles David
    5756 Stonegate Road
    75209 Dallas
    Texas
    Usa
    Segretario
    5756 Stonegate Road
    75209 Dallas
    Texas
    Usa
    American34256160002
    POUND, Stephanie Alison
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Segretario
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    British77355850005
    PRICE, Mairead Brigid
    17 Beech Road
    Hollywood
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    17 Beech Road
    Hollywood
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    British117736250001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Segretario
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    British16575040001
    ASHDOWN, Simon Trayton
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish117331880001
    BAKER, Robert Woodward
    17 Lundys Lane
    75080 Dallas
    Texas
    Usa
    Amministratore
    17 Lundys Lane
    75080 Dallas
    Texas
    Usa
    Usa34900830001
    BROOKS, David Robert
    3412 Centenary Avenue
    Dallas
    Tx75225
    Usa
    Amministratore
    3412 Centenary Avenue
    Dallas
    Tx75225
    Usa
    American48194490001
    BUTLER, Richard John
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish213849970003
    CARTY, Donald John
    3907 Gillon Avenue
    Dallas
    Texas 75205
    Usa
    Amministratore
    3907 Gillon Avenue
    Dallas
    Texas 75205
    Usa
    Canadian,American34256150001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Amministratore
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    British49800090001
    COOPER, Philip William
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish9839440001
    CRANDALL, Robert Lloyd
    5423 Park Lane
    Dallas
    Texas 75220
    Usa
    Amministratore
    5423 Park Lane
    Dallas
    Texas 75220
    Usa
    American46751890001
    ELLIS, John Leslie
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish25380370003
    FERNLEY, Michael John
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Amministratore
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221030001
    FERNLEY, Renee Amy Margaret
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Amministratore
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221020001
    GRAVENEY, Mark
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    British126722400001
    GUNN, George James
    360 E Randolph £3801
    Chicago
    Il 60601
    Usa
    Amministratore
    360 E Randolph £3801
    Chicago
    Il 60601
    Usa
    American48194530001
    MELIZAN, Bruce Anthony
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    United KingdomBritish,Trinidadian92905500001
    METZLER, Thomas Michael
    3918 Fox Glen Drive
    Irving Texas 75062
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    3918 Fox Glen Drive
    Irving Texas 75062
    FOREIGN Usa
    American39634340002
    PLEDGE, Nicholas Christopher
    31 Bolton Crescent
    SL4 3JH Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    31 Bolton Crescent
    SL4 3JH Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish120621490001
    POULTER, Michael John
    Redwood Lodge Pump Lane North
    SL7 3RD Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Redwood Lodge Pump Lane North
    SL7 3RD Marlow
    Buckinghamshire
    British23113980001
    REHILL, Daljit Singh
    102 Berkeley Avenue
    TW4 6LB Hounslow
    Middlesex
    Amministratore
    102 Berkeley Avenue
    TW4 6LB Hounslow
    Middlesex
    British46370490001
    SIBLEY, Anthony William
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritish13317120001
    SIBLEY, Roseleen
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Irish7179710001
    SPENCER, Bernard William
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish98205010002
    WATSON, Michael Stuart
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Amministratore
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish188269720001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Maclellan International Limited
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    06 apr 2016
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Company Law
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03688689
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 27 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 ott 2000
    Consegnato il 06 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 apr 1999
    Consegnato il 26 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or excellence PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 22 ott 1996
    Consegnato il 28 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting agreement and all rights in favour of the company related to such debts and all other amounts and by way of a floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the above amounts as shall for the time being stand released form the fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mar 2023Inizio della liquidazione
    15 mar 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Caroline Rifkind
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0