MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01403501 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Level 12 The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TWO FLAGS EXCELLENCE LIMITED | 15 giu 1999 | 15 giu 1999 |
| TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED | 05 set 1996 | 05 set 1996 |
| AMR TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED | 19 apr 1994 | 19 apr 1994 |
| TWO FLAGS LIMITED | 04 dic 1978 | 04 dic 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 17 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 16 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Stephanie Alison Pound il 23 mag 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Mark Williams il 19 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 dic 2020 al 31 mar 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy Mark Williams come amministratore in data 07 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Maclellan International Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT a Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 02 dic 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Butler come amministratore in data 30 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Katherine Woods come amministratore in data 30 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mitie Company Secretarial Services Limited come segretario in data 30 nov 2020 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephanie Alison Pound come segretario in data 30 nov 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Stephanie Alison Pound il 15 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England |
| 148474450001 | ||||||||||
| POUND, Stephanie Alison | Amministratore | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | England | British | 213930870003 | |||||||||
| WILLIAMS, Jeremy Mark | Amministratore | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | England | British | 280831530001 | |||||||||
| WOODS, Katherine | Amministratore | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | United Kingdom | British | 237400250001 | |||||||||
| BLACKBURN, Peter Edward | Segretario | 1 The Old Orchard CV35 9RW Wellesbourne Warwickshire | British | 75964810001 | ||||||||||
| COOPER, Philip William | Segretario | 34 Alban Road SG6 2AT Letchworth Hertfordshire | British | 9839440001 | ||||||||||
| FERNLEY, Renee Amy Margaret | Segretario | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221020001 | ||||||||||
| GREEN, Kevin Hartley | Segretario | 15 Manor Farm Close Barton Le Clay MK45 4TB Bedford Bedfordshire | British | 72862750001 | ||||||||||
| MARLETT, Charles David | Segretario | 5756 Stonegate Road 75209 Dallas Texas Usa | American | 34256160002 | ||||||||||
| POUND, Stephanie Alison | Segretario | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | British | 77355850005 | ||||||||||
| PRICE, Mairead Brigid | Segretario | 17 Beech Road Hollywood B47 5QS Birmingham West Midlands | British | 117736250001 | ||||||||||
| SHIPLEY, Stephen Robert | Segretario | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | British | 16575040001 | ||||||||||
| ASHDOWN, Simon Trayton | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 117331880001 | |||||||||
| BAKER, Robert Woodward | Amministratore | 17 Lundys Lane 75080 Dallas Texas Usa | Usa | 34900830001 | ||||||||||
| BROOKS, David Robert | Amministratore | 3412 Centenary Avenue Dallas Tx75225 Usa | American | 48194490001 | ||||||||||
| BUTLER, Richard John | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 213849970003 | |||||||||
| CARTY, Donald John | Amministratore | 3907 Gillon Avenue Dallas Texas 75205 Usa | Canadian,American | 34256150001 | ||||||||||
| CLITHEROE, David Maurice | Amministratore | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | 49800090001 | ||||||||||
| COOPER, Philip William | Amministratore | 34 Alban Road SG6 2AT Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 9839440001 | |||||||||
| CRANDALL, Robert Lloyd | Amministratore | 5423 Park Lane Dallas Texas 75220 Usa | American | 46751890001 | ||||||||||
| ELLIS, John Leslie | Amministratore | 21 Oakfields Avenue SG3 6NP Knebworth Hertfordshire | England | British | 25380370003 | |||||||||
| FERNLEY, Michael John | Amministratore | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221030001 | ||||||||||
| FERNLEY, Renee Amy Margaret | Amministratore | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221020001 | ||||||||||
| GRAVENEY, Mark | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | British | 126722400001 | ||||||||||
| GUNN, George James | Amministratore | 360 E Randolph £3801 Chicago Il 60601 Usa | American | 48194530001 | ||||||||||
| MELIZAN, Bruce Anthony | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | United Kingdom | British,Trinidadian | 92905500001 | |||||||||
| METZLER, Thomas Michael | Amministratore | 3918 Fox Glen Drive Irving Texas 75062 FOREIGN Usa | American | 39634340002 | ||||||||||
| PLEDGE, Nicholas Christopher | Amministratore | 31 Bolton Crescent SL4 3JH Windsor Berkshire | England | British | 120621490001 | |||||||||
| POULTER, Michael John | Amministratore | Redwood Lodge Pump Lane North SL7 3RD Marlow Buckinghamshire | British | 23113980001 | ||||||||||
| REHILL, Daljit Singh | Amministratore | 102 Berkeley Avenue TW4 6LB Hounslow Middlesex | British | 46370490001 | ||||||||||
| SIBLEY, Anthony William | Amministratore | Boa Vista Higham Road Higham Gobian SG5 3HR Hitchin Hertfordshire | United Kingdom | British | 13317120001 | |||||||||
| SIBLEY, Roseleen | Amministratore | Boa Vista Higham Road Higham Gobian SG5 3HR Hitchin Hertfordshire | Irish | 7179710001 | ||||||||||
| SPENCER, Bernard William | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 98205010002 | |||||||||
| WATSON, Michael Stuart | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 188269720001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maclellan International Limited | 06 apr 2016 | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12. The Shard England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 14 ott 2004 Consegnato il 27 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 25 ott 2000 Consegnato il 06 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 20 apr 1999 Consegnato il 26 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 mar 1999 Consegnato il 25 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 11 nov 1996 Consegnato il 27 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or excellence PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 22 ott 1996 Consegnato il 28 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting agreement and all rights in favour of the company related to such debts and all other amounts and by way of a floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the above amounts as shall for the time being stand released form the fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0