H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED

H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàH.S. PIPEQUIPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01405862
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi (46720) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Newbury
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Lynne Gilder come amministratore in data 06 ott 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Hs Pipequipment (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS a Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage Newbury Berkshire RG18 9QL in data 22 feb 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 17 nov 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 giu 2016

    Stato del capitale al 20 giu 2016

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2015

    Stato del capitale al 19 giu 2015

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Cessazione della carica di David Norman Reid Kemp come amministratore in data 07 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    18 pagineAA

    Nomina di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 30 nov 2014

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Andrew David Ramage come segretario in data 30 nov 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew David Ramage come amministratore in data 30 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2014

    Stato del capitale al 25 giu 2014

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 11

    2 pagineMR05

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2013 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERETT, Peter John
    Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4BS Farnham
    13
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4BS Farnham
    13
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish98703960003
    MACKENZIE, Derrick Thomas Munro
    Lockview Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8QF Aberdeen
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Lockview Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8QF Aberdeen
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish151716530001
    MCNAIR, Gordon James
    Buckingham Road
    RG14 6DJ Newbury
    38
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Road
    RG14 6DJ Newbury
    38
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177981370001
    HUNT, Barbara Anne
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    British62854160001
    LATHAM, Anthony Robert
    4 Borough High Street
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Segretario
    4 Borough High Street
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British30869320001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    British30869320001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    British30869320001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    RAMAGE, Andrew David
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    174410930001
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    BS1 6JS Bristol
    21 St Thomas Street
    United Kingdom
    Segretario
    BS1 6JS Bristol
    21 St Thomas Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00555893
    97584300001
    ANDRE, Jean Claude
    17 Rue Xaintrailles
    Paris 75013
    France
    Amministratore
    17 Rue Xaintrailles
    Paris 75013
    France
    French38596670001
    CHANDLER, Graham
    1 The Hedgerows
    Chells Manor
    SG2 7DQ Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Hedgerows
    Chells Manor
    SG2 7DQ Stevenage
    Hertfordshire
    British70193540001
    DRAPER, Steven
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British85442360001
    GILDER, Lynne
    Baberton Crescent
    EH4 5BP Edinburgh
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Baberton Crescent
    EH4 5BP Edinburgh
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish174405730001
    HAYES, Kevin Andrew
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish29737760001
    HUCKLE, John Richard William
    15 Homefield Road
    Wimbledon
    SW19 4QF London
    Amministratore
    15 Homefield Road
    Wimbledon
    SW19 4QF London
    British49301820001
    HUNT, Andrew
    Levercrest House
    Eurolink Industrial Estate
    ME10 3RN Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    Levercrest House
    Eurolink Industrial Estate
    ME10 3RN Sittingbourne
    Kent
    British43624370001
    HUNT, Barbara Anne
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    British62854160001
    HUNT, Geoffrey Douglas
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish11605030001
    KEMP, David Norman Reid
    West End
    Bearsden
    G61 1DN Glasgow
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    West End
    Bearsden
    G61 1DN Glasgow
    8
    United Kingdom
    ScotlandBritish109664970001
    LATHAM, Anthony Robert
    4 Borough High Street
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Borough High Street
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British30869320001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    British30869320001
    MARTIN, Anthony
    75 Barrow Point Avenue
    HA5 3HE Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    75 Barrow Point Avenue
    HA5 3HE Pinner
    Middlesex
    British11675410001
    ORROCK, Ian Jackson
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    Amministratore
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    United KingdomBritish34054760010
    RAMAGE, Andrew David
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish174406220002
    SMITH, Leslie Arthur David
    Countryside 13 Salisbury Road
    RG17 0LG Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Countryside 13 Salisbury Road
    RG17 0LG Hungerford
    Berkshire
    British11647970002
    SMITH, Leslie Arthur David
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    British11647970001
    SMITH, Leslie Arthur David
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    British11647970001
    STEWART, Colin
    106 Craigiebuckler Avenue
    AB1 8PA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    106 Craigiebuckler Avenue
    AB1 8PA Aberdeen
    Aberdeenshire
    British12242270001
    WHEELER, David
    64 Church Street
    Great Bedwyn
    SN8 3PF Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    64 Church Street
    Great Bedwyn
    SN8 3PF Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish11675430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hs Pipequipment (Holdings) Limited
    Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Thatcham
    Unit 4
    England
    06 apr 2016
    Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Thatcham
    Unit 4
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione03047787
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 21 mar 2013
    Consegnato il 02 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each UK domiciled loan party to the UK facility secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The specified shares and all related distribution rights the blocked accounts and all monies standing to the credit of such blocked accounts and the debts represented by them all intellectual property rights and all right title and interest in and to the equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America N.a, London Branch
    Transazioni
    • 02 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 28 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 06 dic 2010
    Consegnato il 14 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re H.S. pipequipment limited. Business premium account. Account number 23955362.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 19 ott 2009
    Consegnato il 24 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re H.S. pipequipment limited business premium account account number 03535606.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mag 1995
    Consegnato il 06 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 26 giu 1991
    Consegnato il 16 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395-ref M578C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 nov 1988
    Consegnato il 22 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 ago 1987
    Consegnato il 21 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 03 lug 1986
    Consegnato il 15 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 ott 1985
    Consegnato il 31 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0