H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01405862 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi (46720) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage RG18 9QL Newbury Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lynne Gilder come amministratore in data 06 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Hs Pipequipment (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS a Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage Newbury Berkshire RG18 9QL in data 22 feb 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 17 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David Norman Reid Kemp come amministratore in data 07 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 30 nov 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Ramage come segretario in data 30 nov 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Ramage come amministratore in data 30 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 11 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2013 al 31 mar 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERETT, Peter John | Amministratore | Meadow Way Rowledge GU10 4BS Farnham 13 Surrey United Kingdom | England | British | 98703960003 | |||||||||
| MACKENZIE, Derrick Thomas Munro | Amministratore | Lockview Drive Bridge Of Don AB23 8QF Aberdeen 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 151716530001 | |||||||||
| MCNAIR, Gordon James | Amministratore | Buckingham Road RG14 6DJ Newbury 38 Berkshire United Kingdom | England | British | 177981370001 | |||||||||
| HUNT, Barbara Anne | Segretario | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Thatcham Berkshire | British | 62854160001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Segretario | 4 Borough High Street SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 30869320001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Segretario | Lone Elm 46 Victoria Road OX14 1DQ Abingdon Oxfordshire | British | 30869320001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Segretario | Lone Elm 46 Victoria Road OX14 1DQ Abingdon Oxfordshire | British | 30869320001 | ||||||||||
| PENNINGTON, David Ian | Segretario | Ferndene Applelands Close Boundstone GU10 4TL Farnham Surrey | British | 38346120001 | ||||||||||
| RAMAGE, Andrew David | Segretario | Kimmerghame Place EH4 2GD Edinburgh 1 United Kingdom | 174410930001 | |||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | BS1 6JS Bristol 21 St Thomas Street United Kingdom |
| 97584300001 | ||||||||||
| ANDRE, Jean Claude | Amministratore | 17 Rue Xaintrailles Paris 75013 France | French | 38596670001 | ||||||||||
| CHANDLER, Graham | Amministratore | 1 The Hedgerows Chells Manor SG2 7DQ Stevenage Hertfordshire | British | 70193540001 | ||||||||||
| DRAPER, Steven | Amministratore | London Bridge SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 85442360001 | ||||||||||
| GILDER, Lynne | Amministratore | Baberton Crescent EH4 5BP Edinburgh 28 United Kingdom | United Kingdom | British | 174405730001 | |||||||||
| HAYES, Kevin Andrew | Amministratore | 4 Elm Road SO22 5AG Winchester Hampshire | England | British | 29737760001 | |||||||||
| HUCKLE, John Richard William | Amministratore | 15 Homefield Road Wimbledon SW19 4QF London | British | 49301820001 | ||||||||||
| HUNT, Andrew | Amministratore | Levercrest House Eurolink Industrial Estate ME10 3RN Sittingbourne Kent | British | 43624370001 | ||||||||||
| HUNT, Barbara Anne | Amministratore | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Thatcham Berkshire | British | 62854160001 | ||||||||||
| HUNT, Geoffrey Douglas | Amministratore | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 11605030001 | |||||||||
| KEMP, David Norman Reid | Amministratore | West End Bearsden G61 1DN Glasgow 8 United Kingdom | Scotland | British | 109664970001 | |||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Amministratore | 4 Borough High Street SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 30869320001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Amministratore | Lone Elm 46 Victoria Road OX14 1DQ Abingdon Oxfordshire | British | 30869320001 | ||||||||||
| MARTIN, Anthony | Amministratore | 75 Barrow Point Avenue HA5 3HE Pinner Middlesex | British | 11675410001 | ||||||||||
| ORROCK, Ian Jackson | Amministratore | The Yardhouse Edinample FK19 8QE Loch Earn Perthshire | United Kingdom | British | 34054760010 | |||||||||
| RAMAGE, Andrew David | Amministratore | Kimmerghame Place EH4 2GD Edinburgh 1 United Kingdom | Scotland | British | 174406220002 | |||||||||
| SMITH, Leslie Arthur David | Amministratore | Countryside 13 Salisbury Road RG17 0LG Hungerford Berkshire | British | 11647970002 | ||||||||||
| SMITH, Leslie Arthur David | Amministratore | Squirrel Lodge The Mount Highclere RG15 9RA Newbury Berkshire | British | 11647970001 | ||||||||||
| SMITH, Leslie Arthur David | Amministratore | Squirrel Lodge The Mount Highclere RG15 9RA Newbury Berkshire | British | 11647970001 | ||||||||||
| STEWART, Colin | Amministratore | 106 Craigiebuckler Avenue AB1 8PA Aberdeen Aberdeenshire | British | 12242270001 | ||||||||||
| WHEELER, David | Amministratore | 64 Church Street Great Bedwyn SN8 3PF Marlborough Wiltshire | England | British | 11675430001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hs Pipequipment (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage RG18 9QL Thatcham Unit 4 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
H.S. PIPEQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creato il 21 mar 2013 Consegnato il 02 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each UK domiciled loan party to the UK facility secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The specified shares and all related distribution rights the blocked accounts and all monies standing to the credit of such blocked accounts and the debts represented by them all intellectual property rights and all right title and interest in and to the equipment see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 06 dic 2010 Consegnato il 14 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re H.S. pipequipment limited. Business premium account. Account number 23955362. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 19 ott 2009 Consegnato il 24 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re H.S. pipequipment limited business premium account account number 03535606. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 16 giu 2004 Consegnato il 07 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 30 nov 1995 Consegnato il 15 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 mag 1995 Consegnato il 06 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 26 giu 1991 Consegnato il 16 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See form 395-ref M578C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 01 nov 1988 Consegnato il 22 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 17 ago 1987 Consegnato il 21 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 03 lug 1986 Consegnato il 15 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 25 ott 1985 Consegnato il 31 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0