JAMTILN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAMTILN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01406069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAMTILN LIMITED?

    • (1824) /

    Dove si trova JAMTILN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2276 Dunbeath Road
    Elgin Industrial Estate
    SN2 8EA Swindon
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JAMTILN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS LIMITED 31 dic 197931 dic 1979
    NOUSNOUS LIMITED19 dic 197819 dic 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAMTILN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per JAMTILN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    19 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagine403b

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dividend £1179206.35 16/11/04
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed countdown clean systems LIMITED\certificate issued on 24/11/04
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di JAMTILN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLBROOK, Andrew
    17 Bream Close
    SN11 9UF Calne
    Wiltshire
    Segretario
    17 Bream Close
    SN11 9UF Calne
    Wiltshire
    British90338830002
    HOLBROOK, Andrew
    17 Bream Close
    SN11 9UF Calne
    Wiltshire
    Amministratore
    17 Bream Close
    SN11 9UF Calne
    Wiltshire
    EnglandBritish90338830002
    NORRIS, Michael John
    5 Fitzwilliam Avenue
    TW9 2DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    5 Fitzwilliam Avenue
    TW9 2DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritish78716940001
    BEASLEY, Christopher Ernest
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    Segretario
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    British513720001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    British78519720002
    GREENSALL, Annette
    6 Fold Court
    DY10 4SA Chaddesley Corbet
    Worcestershire
    Segretario
    6 Fold Court
    DY10 4SA Chaddesley Corbet
    Worcestershire
    British73438500001
    MATTU, Balvinder Singh
    Seafield House
    Seafield Lane
    B98 9DL Beoley
    Worcestershire
    Segretario
    Seafield House
    Seafield Lane
    B98 9DL Beoley
    Worcestershire
    British85546560001
    SQUIBB, Peter Ward
    The Cottage Mooredge Road
    Parkhead
    DE4 5GY Matlock
    Derbyshire
    Segretario
    The Cottage Mooredge Road
    Parkhead
    DE4 5GY Matlock
    Derbyshire
    British28531560002
    BEASLEY, Christopher Ernest
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    Amministratore
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    British513720001
    BEASLEY, Christopher Ernest
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    Amministratore
    22 Elm Grove
    N8 9AJ London
    British513720001
    COLCOUGH, Malcolm
    36 Somerville Road
    DE13 7EJ Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    36 Somerville Road
    DE13 7EJ Alrewas
    Staffordshire
    British73390590001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish78519720002
    HANDEL, Elaine
    The Manor House
    Whitwell Worksop
    S80 4QZ Nottinghamshire
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Manor House
    Whitwell Worksop
    S80 4QZ Nottinghamshire
    Nottinghamshire
    British77715960001
    HANDEL, John Michael
    The Manor House
    15 High Street, Whitwell
    S80 4QJ Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Manor House
    15 High Street, Whitwell
    S80 4QJ Worksop
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish109341580001
    HUTCHISON, Andrew Wilson
    Bank House Chesterfield Road
    DE55 7DT Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    Bank House Chesterfield Road
    DE55 7DT Alfreton
    Derbyshire
    British28501520001
    HUTCHISON, Andrew Wilson
    Bank House Chesterfield Road
    DE55 7DT Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    Bank House Chesterfield Road
    DE55 7DT Alfreton
    Derbyshire
    British28501520001
    LAW, John Derek
    44 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    44 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    British513710002
    MATTU, Balvinder Singh
    Seafield House
    Seafield Lane
    B98 9DL Beoley
    Worcestershire
    Amministratore
    Seafield House
    Seafield Lane
    B98 9DL Beoley
    Worcestershire
    British85546560001
    MINTON, Kenneth Joseph
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish513690001
    SCULL, Andrew James
    2 The Granary Brickwall Farm
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 The Granary Brickwall Farm
    Kiln Lane Clophill
    MK45 4DA Bedford
    Bedfordshire
    British53961740001
    SQUIBB, Peter Ward
    The Cottage Mooredge Road
    Parkhead
    DE4 5GY Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    The Cottage Mooredge Road
    Parkhead
    DE4 5GY Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish28531560002
    WILD, Roger Eric
    The Old Rectory
    Holt
    WR6 6NG Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Holt
    WR6 6NG Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish55027460001

    JAMTILN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 05 apr 2001
    Consegnato il 06 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    Unit 7 new york industrial park silverlink wallsend tyne & wear north tyneside t/n TY335410 and land and premises at wimsey way alfreton derbyshire.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC on Behalf of Itself and Those Banks and Financialinstitutions from Time to Time Parties to the Secured Documents
    Transazioni
    • 06 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 nov 2000
    Consegnato il 08 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC on Behalf of Itself and Those Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Secured Documents
    Transazioni
    • 08 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Charge over shares
    Creato il 17 ago 1998
    Consegnato il 02 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from socius group limited (as "principal borrower") and each additional borrower (as defined) to the chargees under the terms of the security documrnts (as defined)
    Brevi particolari
    The shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including dividends interest or income thereon or therefrom) and all related rights thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 02 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as agent and security trustee for the security beneficiaries (as defined) (the "agent") pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 7 new york industrial park, silverlink wallsend tyne and wear t/no: TY335410.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 10 lug 1996
    Consegnato il 22 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations now due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the acquisiton documents the finance documents (as defined) and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JAMTILN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 mar 2010Data di scioglimento
    16 giu 2008Data della petizione
    30 nov 2009Conclusione della liquidazione
    20 ago 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0