HBI INFORMATION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HBI INFORMATION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01406213 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HBI INFORMATION LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HBI INFORMATION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Dorset House Regent Park 297 Kingston Road KT22 7PL Leatherhead Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HBI INFORMATION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ICC INFORMATION LIMITED | 04 dic 1995 | 04 dic 1995 |
| ICC INFORMATION GROUP LIMITED | 22 apr 1985 | 22 apr 1985 |
| ICC INFORMATION LIMITED | 26 mar 1985 | 26 mar 1985 |
| ICC INFORMATION GROUP LIMITED | 27 set 1984 | 27 set 1984 |
| INTER COMPANY COMPARISONS LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| TRADEAST LIMITED | 19 dic 1978 | 19 dic 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HBI INFORMATION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per HBI INFORMATION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Thomas Harris come segretario in data 13 set 2013 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee Robert Williams come segretario in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee Robert Williams come amministratore in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair Gillray Laidlaw come amministratore in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Miguel Oleo come amministratore in data 01 set 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Field House, 72 Oldfield Road, Hampton, Middlesex, TW12 2HQ in data 30 mar 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alastair Laidlaw il 23 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Lee Robert Williams il 23 nov 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Ryden come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Ryden come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HBI INFORMATION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, Geoffrey Thomas | Segretario | Regent Park 297 Kingston Road KT22 7PL Leatherhead Dorset House Surrey United Kingdom | 182207010001 | |||||||
| OLEO BANET, Miguel | Amministratore | Regent Park 297 Kingston Road KT22 7PL Leatherhead Dorset House Surrey United Kingdom | England | Spanish | It Director | 148012910001 | ||||
| GRIFFITHS, Stanley Thomas | Segretario | 53 Cambria Road Ely CF5 4PE Cardiff South Glamorgan | British | 45835010001 | ||||||
| HAMER, Joanne Catherine | Segretario | 13 Hatherop Road TW12 2RG Hampton Middlesex | British | 99616670001 | ||||||
| LAIDLAW, Alastair | Segretario | 9 Lakehill Drive CF71 7HR Cowbridge South Glamorgan | British | 102567840001 | ||||||
| LOVE, Martha | Segretario | Beech Tree Cottage Cotswold Close TW18 2DD Staines Middlesex | British | 51681240002 | ||||||
| RYDEN, Michael Norman | Segretario | 18 Park Gate Mount Avenue W5 1PX Ealing London | British | 16360710003 | ||||||
| RYDEN, Michael Norman | Segretario | 27 Egerton Gardens W13 8HG London | British | 16360710001 | ||||||
| WILLIAMS, Lee Robert | Segretario | Regent Park 297 Kingston Road KT22 7PL Leatherhead Dorset House Surrey United Kingdom | British | Accountant | 131958610001 | |||||
| WILLIAMS, Lee Robert | Segretario | Caeffatri Close CF31 1LZ Bridgend 2 Glamorgan Uk | British | 131958610001 | ||||||
| ARAK, Robin Graeme, Docotr | Amministratore | 104 Parsonage Road BN5 9HZ Henfield Aest Sussex | British | Director | 26967250001 | |||||
| AUSTIN, Michael John Charles | Amministratore | 134 Rivermead Court Ranelagh Gardens SW6 3SE London | British | Accountant | 72546860002 | |||||
| BOWYER, Neil | Amministratore | 166 Winchester Road GU34 5HZ Four Marks Hampshire | British | Director | 76188000001 | |||||
| BURDETT, Angela Susan | Amministratore | 16 Cambridge Cottages Kew Green TW9 3AY Richmond Surrey | British | Company Director | 30282920002 | |||||
| BYRNE, Paul | Amministratore | Marley Grange Avenue Marley Grange Rathfarnham 1 Dublin 16 Ireland | Irish | Managing Director | 137904020001 | |||||
| CHARLESWORTH, Alan Richard | Amministratore | 16 Cherwell Court Broom Park TW11 9RT Teddington Middlesex | British | Managing Director | 43087560001 | |||||
| CHRISTIANSEN, Gordon Peter | Amministratore | Meadow View 39 Long Reach West Horsley KT24 6LZ Leatherhead Surrey | England | British | Manager | 79626160001 | ||||
| CLARKE, Martin Stewart | Amministratore | 4 Fir Tree Cottages Essendon AL9 6AT Hatfield Hertfordshire | British | Director | 4596080001 | |||||
| COYNE, Peter Francis Campbell | Amministratore | 34 Seafield Avenue Clontarf Dublin 3 Ireland | Irish | Company Director | 4725290001 | |||||
| EARLE, Brian Lawrence | Amministratore | 4 Bloom Park Road SW6 7BG London | British | Director | 15300280001 | |||||
| GOODENOUGH, Ian | Amministratore | Swallowfield Copse Southwater RH13 9AZ Horsham Pennock Barn West Sussex United Kingdom | British | Manager | 85150720003 | |||||
| GRIFFITH, Rhian | Amministratore | 9 Westview W7 3DZ London | British | Director | 32127240001 | |||||
| HAWKSWORTH, Therese Patricia, The Executors Of Ms | Amministratore | April Cottage Stone Quarry Road Chelwood Gate RH17 7LP Haywards Heath West Sussex | England | British | Director | 3346870001 | ||||
| HOLMES, Annette Winifred | Amministratore | Flat 99 Garricks House Wadbrook Street KT1 1AZ Kingston Upon Thames Surrey | British | Managing Director | 115651710001 | |||||
| HUISH, Anthony Howard | Amministratore | 34 Heol Aradur Danescourt CF5 2RE Cardiff South Glamorgan | British | Director | 54244280001 | |||||
| JOHANSSON, Mats Karl-Evert | Amministratore | 10 Royston Court TW9 3EH Richmond Surrey | Swedish | Director | 22176400001 | |||||
| JOHNSTON, David Ritchie | Amministratore | 9 Norris Acre Hinton In The Hedges NN13 5NN Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | Publisher | 72143970001 | ||||
| LAIDLAW, Alastair Gillray | Amministratore | Regent Park 297 Kingston Road KT22 7PL Leatherhead Dorset House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 102567840002 | ||||
| LAMBIE, Sheila Morne | Amministratore | 19 Westmount Road KT10 9BE Hinchley Wood Surrey | British | Director | 57479570001 | |||||
| LOVE, Martha | Amministratore | Beech Tree Cottage Cotswold Close TW18 2DD Staines Middlesex | England | British | Accountant | 51681240002 | ||||
| MCVEY, Robert Graham | Amministratore | Applecross Dene Road KT21 1EE Ashtead Surrey | British | Director | 71265310001 | |||||
| NAISBITT, Peter | Amministratore | 25 Fairmount Road SW2 2BJ London | British | Technical Director | 36543900001 | |||||
| PAULINE, Alistair David | Amministratore | Greenacre 5 Llantwit Major Road CF71 7JP Cowbridge Vale Of Glamorgan | Wales | British | Accountant | 45835080002 | ||||
| RYDEN, Michael Norman | Amministratore | 18 Park Gate Mount Avenue W5 1PX Ealing London | Uk | British | Company Secretary | 16360710003 | ||||
| SAVE, Lars | Amministratore | Rodstuguvagen 27b Lidingo S 18130 Sweden | Swedish | Company Director | 45835400002 |
HBI INFORMATION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creato il 06 apr 1998 Consegnato il 21 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the bank under each of the financing documents (as defined) to which such obligor is a party and all costs charges and expenses icurred by the bank in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the financing documents (the "secured liabilities") | |
Brevi particolari F/H 72 oldfield road hampton surrey t/n sgl 402221. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 03 feb 1992 Consegnato il 07 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents | |
Brevi particolari Freehold land known as 96 whitchurch road,cardiff,south glamorgan freehold land known as 110 whitchurch road,cardiff,south glamorgan see doc ref M237 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 dic 1988 Consegnato il 05 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 14 ott 1988 Consegnato il 03 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 110 whitchurch road cordiff community south glomrgan t/no wa 124872. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 14 ott 1988 Consegnato il 03 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 96 whitchurch road cardiff community south glomorgan t/n wa 39939. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 giu 1987 Consegnato il 12 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee the terms of a presuant bond dated 22/5/87 | |
Brevi particolari Heritable presuant at 3, hill street, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 feb 1987 Consegnato il 05 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 110 whitchurch road cardiff community south glomorgan t/no wa 124872. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 feb 1987 Consegnato il 05 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 96 whitchurch road cardiff south glamorgan t/no wa 39939. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee debenture | Creato il 06 ott 1981 Consegnato il 12 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, with all buildings & fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0