HBI INFORMATION LIMITED

HBI INFORMATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHBI INFORMATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01406213
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HBI INFORMATION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HBI INFORMATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dorset House Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Surrey
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HBI INFORMATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICC INFORMATION LIMITED04 dic 199504 dic 1995
    ICC INFORMATION GROUP LIMITED22 apr 198522 apr 1985
    ICC INFORMATION LIMITED26 mar 198526 mar 1985
    ICC INFORMATION GROUP LIMITED27 set 198427 set 1984
    INTER COMPANY COMPARISONS LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    TRADEAST LIMITED19 dic 197819 dic 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di HBI INFORMATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HBI INFORMATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Geoffrey Thomas Harris come segretario in data 13 set 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lee Robert Williams come segretario in data 13 set 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lee Robert Williams come amministratore in data 13 set 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alastair Gillray Laidlaw come amministratore in data 13 set 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Miguel Oleo come amministratore in data 01 set 2013

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2012

    Stato del capitale al 24 dic 2012

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Field House, 72 Oldfield Road, Hampton, Middlesex, TW12 2HQ in data 30 mar 2011

    1 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Alastair Laidlaw il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Lee Robert Williams il 23 nov 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Michael Ryden come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael Ryden come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HBI INFORMATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRIS, Geoffrey Thomas
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    182207010001
    OLEO BANET, Miguel
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandSpanishIt Director148012910001
    GRIFFITHS, Stanley Thomas
    53 Cambria Road
    Ely
    CF5 4PE Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    53 Cambria Road
    Ely
    CF5 4PE Cardiff
    South Glamorgan
    British45835010001
    HAMER, Joanne Catherine
    13 Hatherop Road
    TW12 2RG Hampton
    Middlesex
    Segretario
    13 Hatherop Road
    TW12 2RG Hampton
    Middlesex
    British99616670001
    LAIDLAW, Alastair
    9 Lakehill Drive
    CF71 7HR Cowbridge
    South Glamorgan
    Segretario
    9 Lakehill Drive
    CF71 7HR Cowbridge
    South Glamorgan
    British102567840001
    LOVE, Martha
    Beech Tree Cottage
    Cotswold Close
    TW18 2DD Staines
    Middlesex
    Segretario
    Beech Tree Cottage
    Cotswold Close
    TW18 2DD Staines
    Middlesex
    British51681240002
    RYDEN, Michael Norman
    18 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX Ealing
    London
    Segretario
    18 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX Ealing
    London
    British16360710003
    RYDEN, Michael Norman
    27 Egerton Gardens
    W13 8HG London
    Segretario
    27 Egerton Gardens
    W13 8HG London
    British16360710001
    WILLIAMS, Lee Robert
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    BritishAccountant131958610001
    WILLIAMS, Lee Robert
    Caeffatri Close
    CF31 1LZ Bridgend
    2
    Glamorgan
    Uk
    Segretario
    Caeffatri Close
    CF31 1LZ Bridgend
    2
    Glamorgan
    Uk
    British131958610001
    ARAK, Robin Graeme, Docotr
    104 Parsonage Road
    BN5 9HZ Henfield
    Aest Sussex
    Amministratore
    104 Parsonage Road
    BN5 9HZ Henfield
    Aest Sussex
    BritishDirector26967250001
    AUSTIN, Michael John Charles
    134 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SE London
    Amministratore
    134 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SE London
    BritishAccountant72546860002
    BOWYER, Neil
    166 Winchester Road
    GU34 5HZ Four Marks
    Hampshire
    Amministratore
    166 Winchester Road
    GU34 5HZ Four Marks
    Hampshire
    BritishDirector76188000001
    BURDETT, Angela Susan
    16 Cambridge Cottages
    Kew Green
    TW9 3AY Richmond
    Surrey
    Amministratore
    16 Cambridge Cottages
    Kew Green
    TW9 3AY Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director30282920002
    BYRNE, Paul
    Marley Grange Avenue
    Marley Grange
    Rathfarnham
    1
    Dublin 16
    Ireland
    Amministratore
    Marley Grange Avenue
    Marley Grange
    Rathfarnham
    1
    Dublin 16
    Ireland
    IrishManaging Director137904020001
    CHARLESWORTH, Alan Richard
    16 Cherwell Court
    Broom Park
    TW11 9RT Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    16 Cherwell Court
    Broom Park
    TW11 9RT Teddington
    Middlesex
    BritishManaging Director43087560001
    CHRISTIANSEN, Gordon Peter
    Meadow View 39 Long Reach
    West Horsley
    KT24 6LZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Meadow View 39 Long Reach
    West Horsley
    KT24 6LZ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishManager79626160001
    CLARKE, Martin Stewart
    4 Fir Tree Cottages
    Essendon
    AL9 6AT Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Fir Tree Cottages
    Essendon
    AL9 6AT Hatfield
    Hertfordshire
    BritishDirector4596080001
    COYNE, Peter Francis Campbell
    34 Seafield Avenue
    Clontarf
    Dublin 3
    Ireland
    Amministratore
    34 Seafield Avenue
    Clontarf
    Dublin 3
    Ireland
    IrishCompany Director4725290001
    EARLE, Brian Lawrence
    4 Bloom Park Road
    SW6 7BG London
    Amministratore
    4 Bloom Park Road
    SW6 7BG London
    BritishDirector15300280001
    GOODENOUGH, Ian
    Swallowfield Copse
    Southwater
    RH13 9AZ Horsham
    Pennock Barn
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Swallowfield Copse
    Southwater
    RH13 9AZ Horsham
    Pennock Barn
    West Sussex
    United Kingdom
    BritishManager85150720003
    GRIFFITH, Rhian
    9 Westview
    W7 3DZ London
    Amministratore
    9 Westview
    W7 3DZ London
    BritishDirector32127240001
    HAWKSWORTH, Therese Patricia, The Executors Of Ms
    April Cottage Stone Quarry Road
    Chelwood Gate
    RH17 7LP Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    April Cottage Stone Quarry Road
    Chelwood Gate
    RH17 7LP Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritishDirector3346870001
    HOLMES, Annette Winifred
    Flat 99 Garricks House
    Wadbrook Street
    KT1 1AZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Flat 99 Garricks House
    Wadbrook Street
    KT1 1AZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishManaging Director115651710001
    HUISH, Anthony Howard
    34 Heol Aradur
    Danescourt
    CF5 2RE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    34 Heol Aradur
    Danescourt
    CF5 2RE Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector54244280001
    JOHANSSON, Mats Karl-Evert
    10 Royston Court
    TW9 3EH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    10 Royston Court
    TW9 3EH Richmond
    Surrey
    SwedishDirector22176400001
    JOHNSTON, David Ritchie
    9 Norris Acre
    Hinton In The Hedges
    NN13 5NN Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    9 Norris Acre
    Hinton In The Hedges
    NN13 5NN Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritishPublisher72143970001
    LAIDLAW, Alastair Gillray
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Regent Park
    297 Kingston Road
    KT22 7PL Leatherhead
    Dorset House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector102567840002
    LAMBIE, Sheila Morne
    19 Westmount Road
    KT10 9BE Hinchley Wood
    Surrey
    Amministratore
    19 Westmount Road
    KT10 9BE Hinchley Wood
    Surrey
    BritishDirector57479570001
    LOVE, Martha
    Beech Tree Cottage
    Cotswold Close
    TW18 2DD Staines
    Middlesex
    Amministratore
    Beech Tree Cottage
    Cotswold Close
    TW18 2DD Staines
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant51681240002
    MCVEY, Robert Graham
    Applecross Dene Road
    KT21 1EE Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Applecross Dene Road
    KT21 1EE Ashtead
    Surrey
    BritishDirector71265310001
    NAISBITT, Peter
    25 Fairmount Road
    SW2 2BJ London
    Amministratore
    25 Fairmount Road
    SW2 2BJ London
    BritishTechnical Director36543900001
    PAULINE, Alistair David
    Greenacre 5 Llantwit Major Road
    CF71 7JP Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Greenacre 5 Llantwit Major Road
    CF71 7JP Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishAccountant45835080002
    RYDEN, Michael Norman
    18 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX Ealing
    London
    Amministratore
    18 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX Ealing
    London
    UkBritishCompany Secretary16360710003
    SAVE, Lars
    Rodstuguvagen 27b
    Lidingo
    S 18130
    Sweden
    Amministratore
    Rodstuguvagen 27b
    Lidingo
    S 18130
    Sweden
    SwedishCompany Director45835400002

    HBI INFORMATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 06 apr 1998
    Consegnato il 21 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the bank under each of the financing documents (as defined) to which such obligor is a party and all costs charges and expenses icurred by the bank in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the financing documents (the "secured liabilities")
    Brevi particolari
    F/H 72 oldfield road hampton surrey t/n sgl 402221. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nordbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 21 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 07 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents
    Brevi particolari
    Freehold land known as 96 whitchurch road,cardiff,south glamorgan freehold land known as 110 whitchurch road,cardiff,south glamorgan see doc ref M237 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nordbanken,London Branch(The "Bank")
    Transazioni
    • 07 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1988
    Consegnato il 05 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 ott 1988
    Consegnato il 03 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    110 whitchurch road cordiff community south glomrgan t/no wa 124872.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 ott 1988
    Consegnato il 03 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    96 whitchurch road cardiff community south glomorgan t/n wa 39939.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 1987
    Consegnato il 12 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee the terms of a presuant bond dated 22/5/87
    Brevi particolari
    Heritable presuant at 3, hill street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1987
    Consegnato il 05 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    110 whitchurch road cardiff community south glomorgan t/no wa 124872.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1987
    Consegnato il 05 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    96 whitchurch road cardiff south glamorgan t/no wa 39939.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee debenture
    Creato il 06 ott 1981
    Consegnato il 12 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, with all buildings & fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0