LEISURE TENNIS LIMITED

LEISURE TENNIS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEISURE TENNIS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01409437
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEISURE TENNIS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova LEISURE TENNIS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    40-44 Coombe Road
    KT3 4QF New Malden
    Surrey
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEISURE TENNIS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per LEISURE TENNIS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 17 dic 2010

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cannons House 40-44 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QF in data 22 giu 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    12 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LEISURE TENNIS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLBEN, David George
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    Segretario
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    British104903050001
    DOYLE, Kevan-Peter
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish78237230007
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    GILES, Alan Patrick
    Blake Lodge Bridge Lane
    SW11 3AD London
    Segretario
    Blake Lodge Bridge Lane
    SW11 3AD London
    American30339590002
    OLIVER, Martin Timothy
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    Segretario
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    British50764370001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Segretario
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British63240980001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Segretario
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    British40530270001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Segretario
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    British50807620002
    ANDREW, James Richard Elliott
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    Amministratore
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    United KingdomBritish139764120001
    BECKWITH, Peter Michael
    29 Marryat Road
    SW19 London
    Amministratore
    29 Marryat Road
    SW19 London
    British44336530001
    BOTTS, Theodore Paul
    15 Kensington Gate
    W8 5NA London
    Amministratore
    15 Kensington Gate
    W8 5NA London
    Usa30900120001
    FISH, Mark Andrew
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish44086510002
    GAY, Philip
    115 Altenburg Gardens
    SW11 1JQ London
    Amministratore
    115 Altenburg Gardens
    SW11 1JQ London
    British44336430001
    GILES, Alan Patrick
    12 Colestown Street
    SW11 3EH London
    Amministratore
    12 Colestown Street
    SW11 3EH London
    American30339590001
    HARRIS, Martin
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    Amministratore
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    British75882330001
    HAWKINS, Jonathan Francis Whishaw
    24 Formosa Street
    W9 2QA London
    Amministratore
    24 Formosa Street
    W9 2QA London
    British22150090001
    HOLMES, Andrew James
    Ivy House
    Culworth
    OX17 2AZ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ivy House
    Culworth
    OX17 2AZ Banbury
    Oxfordshire
    British3046170001
    JESSOP, Christopher
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    Amministratore
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    United KingdomBritish139864830001
    MEJIA, Carlos Jaime
    26 Mallord Street
    SW3 6DU London
    Amministratore
    26 Mallord Street
    SW3 6DU London
    Colombian30900140001
    MISRA, Arnu Kumar
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritish227695390001
    OLIVER, Martin Timothy
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    British50764370002
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Amministratore
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritish63240980001
    SOLER, Francisco Angel
    Paseo Escalon 5150
    FOREIGN San Salvador
    Elsalvador
    Amministratore
    Paseo Escalon 5150
    FOREIGN San Salvador
    Elsalvador
    El SalvadorSalvadorean30900130001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Amministratore
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    United KingdomBritish40530270001
    TEGELAARS, Harm Bartholomew
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    Amministratore
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    UkDutch16805470001
    WILLIAMS, Christopher
    6 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    6 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British102280630002
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    EnglandBritish50807620002

    LEISURE TENNIS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed to a debenture dated 10 may 2001 between inter alia,health club investments limited (the "parent"),health club investments limited and health club acquisitions limited (the "charging companies") and the royal bank of scotland PLC (the "security agent") (the "debenture")
    Creato il 03 lug 2001
    Consegnato il 13 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) to any secured party (as defined) or any other obligor (as defined) in any manner under or in respect of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1995
    Consegnato il 19 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 giu 1995
    Consegnato il 15 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the south east side of townmead road, fulham, london t/no. NGL590444. Fixed charge over all buildings and other structures and items fixed to the property and any goodwill relating to the property. Fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods used in connection with the property. Assignment of the rental sums and the benefit of all rights and remedies of the company. Fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 12 mar 1992
    Consegnato il 30 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 16THDECENBER 1991
    Brevi particolari
    Its right title and interest in and to the assigned agreements (see form 395 forfull details).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 18 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility letter or any guarantee or security as defined
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the bovis agreement and the accounts (see doc ref M122 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 18 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 16TH december 1991
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 18 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 16THDECEMBER 1991
    Brevi particolari
    Right title and interest in and to the construction contract dated 25TH november 1991 between the company and conder uklimited (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 07 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a the land on the south east side of townmead road fulham london SW6 title no: ngl 590444.
    Persone aventi diritto
    • Dallanty Holdings N.V.
    Transazioni
    • 07 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 1988
    Consegnato il 03 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    London the s/e side of townmead road fulham, l/b of hammersmith & fulham t/n ngl 590444 (for full details see form 395). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    Transazioni
    • 03 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 ago 1988
    Consegnato il 03 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    Transazioni
    • 03 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1987
    Consegnato il 07 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,820,000 due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Land at townmead, fulham forming part of t/no. 425439 & ngl 457486.
    Persone aventi diritto
    • Packestrel Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge of cash deposits
    Creato il 09 giu 1986
    Consegnato il 11 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £130,000
    Brevi particolari
    A cash deposit in the sum of £130,000.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston.
    Transazioni
    • 11 giu 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0