MFI PROPERTIES LIMITED

MFI PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMFI PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01410500
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MFI PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova MFI PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MFI PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRUSHELFCO (NO. 205) LIMITED19 gen 197919 gen 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di MFI PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al19 mag 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per MFI PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ott 2013

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 apr 2013

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 apr 2013

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ott 2012

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 apr 2012

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ott 2011

    5 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB in data 26 mag 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 apr 2011

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ in data 11 mar 2011

    2 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Chi sono gli amministratori di MFI PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Segretario
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    FAVELL, Gary Alan
    Brickendon Lane
    Brickendon
    SG13 8NU Hertford
    Bourne Orchard
    United Kingdom
    Amministratore
    Brickendon Lane
    Brickendon
    SG13 8NU Hertford
    Bourne Orchard
    United Kingdom
    EnglandBritish107699240002
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    HUGHES, Gerard Maxwell
    39 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    Segretario
    39 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    British70698270003
    OKAI, Maade
    3a Gainsborough Road
    N12 8AA Finchley
    London
    Segretario
    3a Gainsborough Road
    N12 8AA Finchley
    London
    British84554260001
    THOMSON, Hamish Noel Michael
    Widmere Cottage
    Pheasants
    RG9 6NH Hambleden On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Widmere Cottage
    Pheasants
    RG9 6NH Hambleden On Thames
    Oxfordshire
    British21957690001
    BROCK, David Michael
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish22121020001
    CLIFFORD-KING, Martin
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British77456620001
    HANCOCK, John Michael
    Mfi Furniture Group Plc
    333 The Hyde, Edgeware Road
    NW9 6TD London
    Amministratore
    Mfi Furniture Group Plc
    333 The Hyde, Edgeware Road
    NW9 6TD London
    American,British63302170004
    HUNT, Derek Simpson
    Hunters Oak
    Asheridge
    HP5 2UV Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hunters Oak
    Asheridge
    HP5 2UV Chesham
    Buckinghamshire
    British18973420001
    MACDONALD, Gordon
    2 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    British61899480001
    MCMANUS, James
    Riversmeet
    4 Amy Lane
    HP5 1NA Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Riversmeet
    4 Amy Lane
    HP5 1NA Chesham
    Buckinghamshire
    British33209620001
    MURPHY, Susan Margaret
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish49990470002
    O'CONNELL, John Joseph
    15 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    15 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    British21957700002
    RANDALL, John David
    335 The Hyde Edgware Road
    Colindale
    NW9 6TD London
    Amministratore
    335 The Hyde Edgware Road
    Colindale
    NW9 6TD London
    British67962100001
    REGAN, Geoff
    176 Kings Hall Road
    BR3 1LJ Beckenham
    Kent
    Amministratore
    176 Kings Hall Road
    BR3 1LJ Beckenham
    Kent
    British101040780001
    ROBSON, Mark Philip William
    14 Bathgate Road
    SW19 5PN London
    Amministratore
    14 Bathgate Road
    SW19 5PN London
    United KingdomBritish63367580002
    WILKINSON, Christopher Robert
    112 Gregories Road
    HP9 1HT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    112 Gregories Road
    HP9 1HT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69562000001

    MFI PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 november 2006 and
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 02 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land extending in the parish of dunfermline and county of fife,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mep Mayflower Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 november 2006 and
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 02 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land extending in the parish of dunfermline and county of fife,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mep Mayflower (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 27 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mep Mayflower (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 27 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mep Mayflower Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First supplemental legal charge which is supplemental to a debenture dated 17 february 2006 and
    Creato il 04 apr 2006
    Consegnato il 13 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mfi UK limited and howden joinery limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property at manchester road bolton, t/n's GM379092 GM956984,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited (As Security Trustee for the Pension Trustees)
    Transazioni
    • 13 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First supplemental legal charge
    Creato il 04 apr 2006
    Consegnato il 07 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H manchester road bolton t/nos GM379092 and GM956984 and land at concorde way eaglecliffe stockton on tees t/nos CE50479, CE160392 and CE117024. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 07 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 21/02/06 and
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 04 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the plot or area of ground extending to one acre and forty one decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure at milesmark in the parish of dunfermline and county of fife together with fittings and fixtures, privileges and pertinents, whole right title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21/02/06 and
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground extending to one acre and forty one decimal or one hundreth parts of an acre or thereby imperial standard measure at milemark in the parish of dunfermline and county of fife. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mfi UK limited and howden joinery limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the howdens shares being the issued share capital in howdens specified as belonging to orchardlight and all other stocks shares or securities the mortgaged properties being f/h land and buildings at the hyde edgware road london t/nos MX376998 NGL455590 f/h thorpe road howden t/nos HS263751 HS121975 and f/h unit 2 atlantic street altrincham broadheath t/no GM372952 (for details of further properties charged please refer to the form 395) and each floating charge property and all its other assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Pension Trustees)
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 21 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H southon house 333 the hyde edgware road london t/no mx 376998 and ngl 455590, f/h thorpe road howden t/nos hs 263751 and hs 121975 and f/h unit 2 atlantic street altrincham street altrincham broadheath t/no gm 372952. for details of further properties charged please refer to deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burndale Financial Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 26 ott 1999
    Consegnato il 05 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 05 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 01 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The monies secured by a composite guarantee and debenture dated 16/11/87 due to the chargee as trustee for the beneficiaries
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 6 parc trostre llanelli dyfed (please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 01 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 feb 1992
    Consegnato il 03 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in a mortgage or charge dated 19/11/87.
    Brevi particolari
    L/H property situated and k/a part of shannon corner new malden surry. And all buildings and fixtures (including trade fixtures).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC(As Security Agent Acting as Trustee for the Beneficiaries as Defined).
    Transazioni
    • 03 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 07 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company to the law debenture trust corporation PLC as security agent acting as trustee for the beneficiaries as defined under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property part of unit J1 liver ind est aintree,merseyside,liverpool t/no.ms 94166 and all buildings etc.
    Persone aventi diritto
    • See Form 395 for Details
    Transazioni
    • 07 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 ott 1991
    Consegnato il 02 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H unit A2 old brighton road, lowfield heath, crawley, west sussex, title no sgl 268833 & all buildings & fixtures (including trade fixtures).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Security Agent Acting as Trustee Fotr the Beneficiaries
    Transazioni
    • 02 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 ago 1991
    Consegnato il 21 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent as trustee for the beneficianies (as defined).
    Brevi particolari
    L/H part of unit a, 190/200 thornton road, croydon title no sgl 268833 & all buildings & fixtures (including trade fixtures).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 09 lug 1991
    Consegnato il 10 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30/1/79
    Brevi particolari
    The sum of £182,500 to be held by the landlord on deposit in a separte designated account at the bennet scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Provident Institution
    Transazioni
    • 10 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 mag 1991
    Consegnato il 05 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due to become due from mfi furniture group limited under the terms of a composite guarantee and debenture dated 16.11.87 and this charge. To the chargee.
    Brevi particolari
    L/H property k/a 138, 140 and 142 london road portsmouth hampshire (and all buildings & fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trlist Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries (As Theriendefined)
    Transazioni
    • 05 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 apr 1991
    Consegnato il 18 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mfi furniture group limited 1 to the chargee. As trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the composite guarantee & debenture dated 16/11/87
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 2 london road, newbury & all buildings & fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property (see form 395 or full details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 18 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 feb 1991
    Consegnato il 02 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee the security agent as trustee for the beneficiaries (as defined) under the terms of the composite guarantee and debenture dated 16/11/87
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 4 retail park southend arterial road, basildon essex & all building and fixtures (including trade fixtures rom time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporationthe Security Agent as Trustee for the Beneficiaries (As Shown on Form 395)
    Transazioni
    • 02 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 23 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries as defined pursuant to a facility agreement dated 13.11.87 and under the terms of the debenture.
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 7 withybush retail park haverfordwest, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) (see form 395 for complete details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee debenture
    Creato il 20 nov 1990
    Consegnato il 28 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 2 chapel lane selly oak west midlands, together with all buildings fixtures (including trade fixtures) (see rom 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 28 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 01 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the law debenture trust corppration PLC as trustee for the beneficiaries under the terms of a composite guarante dated 16/11/87
    Brevi particolari
    Unit b portview road, avonmouth, bristol, avon and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time on the property. (See form 395, pages 5 and 6 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1990
    Consegnato il 20 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as under the terms of a composite guarantee and debenture dated 16/11/87
    Brevi particolari
    Unit knaves beech business centre high wycombe and all buildings at fixture including trade fixtures.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporatin Plcas Trustee for the Beneficicres
    Transazioni
    • 20 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MFI PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 apr 2010Fine dell'amministrazione
    06 ott 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praticante
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Praticante
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    09 mar 2014Data di scioglimento
    13 apr 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0