MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED

MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01411614
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Building 1, 1st Floor Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARCH PACKAGING LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    PESSUAR LIMITED25 gen 197925 gen 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 dic 2010

    Stato del capitale al 06 dic 2010

    • Capitale: GBP 5,026.63
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Joseph Schoonbrood come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Herwig Stuerzenbecher come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per Graham Peter Fenwick il 10 nov 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Carol Anne Hunt il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FENWICK, Graham Peter
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    Segretario
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    British131239950001
    HUNT, Carol Anne
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    Amministratore
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Secretary117672970002
    STUERZENBECHER, Herwig
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    Amministratore
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    AustriaAustrianCompany Director151802760001
    ALLAN, Francis Thomas
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    Segretario
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    BritishDirector43667810001
    BLAKEY, David John
    24 Dowhills Road
    Crosby
    L23 8SW Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    24 Dowhills Road
    Crosby
    L23 8SW Liverpool
    Merseyside
    BritishChartered Accountant28774220002
    NEAVE, John Leslie
    South Court
    North Trade Road
    TN33 0HN Battle
    East Sussex
    Segretario
    South Court
    North Trade Road
    TN33 0HN Battle
    East Sussex
    British23640580001
    ALLAN, Francis Thomas
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    Amministratore
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    BritishDirector43667810001
    BLACKFORD, Christopher Fitzgerald
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    Amministratore
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    BritishCompany Director61034050002
    CARRIHILL, Gordon Ian
    Azela Cottage
    Warfield Street
    RG42 6BG Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    Azela Cottage
    Warfield Street
    RG42 6BG Warfield
    Berkshire
    South AfricanDirector78135680001
    DOVE, Anthony Noy
    Westbank House Ellerslie Lane
    TN39 4LJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    Amministratore
    Westbank House Ellerslie Lane
    TN39 4LJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    BritishSales Director3403050001
    ECCLESTON, John Leslie
    12 Davenport Way
    Seabridge
    ST5 3TX Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    12 Davenport Way
    Seabridge
    ST5 3TX Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director91674860001
    KING, Gary Dennis, Dr
    The Warren
    Llanarmon Yn Lal
    CH7 4QW Mold
    Clwyd
    Amministratore
    The Warren
    Llanarmon Yn Lal
    CH7 4QW Mold
    Clwyd
    BritishManager63444430002
    NEAVE, John Leslie
    South Court
    North Trade Road
    TN33 0HN Battle
    East Sussex
    Amministratore
    South Court
    North Trade Road
    TN33 0HN Battle
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director23640580001
    PARSONS, Charles Martin
    18 Belgravia Gardens
    Hale
    WA15 0JT Altrincham
    Amministratore
    18 Belgravia Gardens
    Hale
    WA15 0JT Altrincham
    BritishManaging Director44546820002
    POWELL, Alan
    38 Wicks Lane
    Formby
    L37 1PX Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    38 Wicks Lane
    Formby
    L37 1PX Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector38753400001
    PROKOPOWICZ, Zbigniew
    40 Derby Road
    Beeston
    NG9 2TG Nottingham
    Amministratore
    40 Derby Road
    Beeston
    NG9 2TG Nottingham
    FrenchCompany Director85888260002
    SCHOONBROOD, Joseph Hubertus Anna Raymundus
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    Amministratore
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building 1, 1st Floor
    Surrey
    NetherlandsDutchDirector108094620001

    MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 ago 1992
    Consegnato il 12 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h land having an area of approx 1.25 acres or thereabouts together with the buildings erected thereon and k/a plot 86 walworth ind est andover test valley hampshire fixed charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment by way of charge
    Creato il 24 mag 1990
    Consegnato il 06 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that agreement dated 23-1-90 relating to land having an area of approx 1.25 acres or thereabouts situate & being plot 86 wallworth ind est an dover test valley hampshire & all the benefit thereof. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 06 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 21 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 1988
    Consegnato il 26 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & building k/a unit C5 northfleet industrial estate, northfleet gravesham, dartford, kent title no. K 628006.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 1985
    Consegnato il 05 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot a castleham employment area hastings east sussex T.N. ht 13217. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank LTD.
    Transazioni
    • 05 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 gen 1981
    Consegnato il 02 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank LTD
    Transazioni
    • 02 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0