MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01411614 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Building 1, 1st Floor Aviator Park Station Road KT15 2PG Addlestone Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MARCH PACKAGING LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
PESSUAR LIMITED | 25 gen 1979 | 25 gen 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joseph Schoonbrood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Herwig Stuerzenbecher come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Graham Peter Fenwick il 10 nov 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood il 01 nov 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Carol Anne Hunt il 20 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a |
Chi sono gli amministratori di MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENWICK, Graham Peter | Segretario | Aviator Park Station Road KT15 2PG Addlestone Building 1, 1st Floor Surrey | British | 131239950001 | ||||||
HUNT, Carol Anne | Amministratore | Aviator Park Station Road KT15 2PG Addlestone Building 1, 1st Floor Surrey | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 117672970002 | ||||
STUERZENBECHER, Herwig | Amministratore | Aviator Park Station Road KT15 2PG Addlestone Building 1, 1st Floor Surrey | Austria | Austrian | Company Director | 151802760001 | ||||
ALLAN, Francis Thomas | Segretario | 7 Courtney Way CB4 2EE Cambridge | British | Director | 43667810001 | |||||
BLAKEY, David John | Segretario | 24 Dowhills Road Crosby L23 8SW Liverpool Merseyside | British | Chartered Accountant | 28774220002 | |||||
NEAVE, John Leslie | Segretario | South Court North Trade Road TN33 0HN Battle East Sussex | British | 23640580001 | ||||||
ALLAN, Francis Thomas | Amministratore | 7 Courtney Way CB4 2EE Cambridge | British | Director | 43667810001 | |||||
BLACKFORD, Christopher Fitzgerald | Amministratore | . Dovecote Church Road, Walpole St Peter PE14 7NS Wisbech | British | Company Director | 61034050002 | |||||
CARRIHILL, Gordon Ian | Amministratore | Azela Cottage Warfield Street RG42 6BG Warfield Berkshire | South African | Director | 78135680001 | |||||
DOVE, Anthony Noy | Amministratore | Westbank House Ellerslie Lane TN39 4LJ Bexhill On Sea East Sussex | British | Sales Director | 3403050001 | |||||
ECCLESTON, John Leslie | Amministratore | 12 Davenport Way Seabridge ST5 3TX Newcastle Under Lyme Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 91674860001 | ||||
KING, Gary Dennis, Dr | Amministratore | The Warren Llanarmon Yn Lal CH7 4QW Mold Clwyd | British | Manager | 63444430002 | |||||
NEAVE, John Leslie | Amministratore | South Court North Trade Road TN33 0HN Battle East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 23640580001 | ||||
PARSONS, Charles Martin | Amministratore | 18 Belgravia Gardens Hale WA15 0JT Altrincham | British | Managing Director | 44546820002 | |||||
POWELL, Alan | Amministratore | 38 Wicks Lane Formby L37 1PX Liverpool Merseyside | British | Director | 38753400001 | |||||
PROKOPOWICZ, Zbigniew | Amministratore | 40 Derby Road Beeston NG9 2TG Nottingham | French | Company Director | 85888260002 | |||||
SCHOONBROOD, Joseph Hubertus Anna Raymundus | Amministratore | Aviator Park Station Road KT15 2PG Addlestone Building 1, 1st Floor Surrey | Netherlands | Dutch | Director | 108094620001 |
MARCH PACKAGING (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 06 ago 1992 Consegnato il 12 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h land having an area of approx 1.25 acres or thereabouts together with the buildings erected thereon and k/a plot 86 walworth ind est andover test valley hampshire fixed charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment by way of charge | Creato il 24 mag 1990 Consegnato il 06 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that agreement dated 23-1-90 relating to land having an area of approx 1.25 acres or thereabouts situate & being plot 86 wallworth ind est an dover test valley hampshire & all the benefit thereof. (See form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 set 1988 Consegnato il 26 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & building k/a unit C5 northfleet industrial estate, northfleet gravesham, dartford, kent title no. K 628006. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 feb 1985 Consegnato il 05 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H plot a castleham employment area hastings east sussex T.N. ht 13217. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 gen 1981 Consegnato il 02 feb 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0