ABBEYCREST PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABBEYCREST PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01411796
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABBEYCREST PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova ABBEYCREST PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Hollins Mount
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABBEYCREST PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABBEYCREST MANUFACTURING JEWELLERS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    ABBEY CREST (WHOLESALE JEWELLERS) LIMITED26 gen 197926 gen 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEYCREST PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ABBEYCREST PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 feb 2013

    16 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 04 feb 2013

    16 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 05 ago 2012

    15 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Elma House Beaconsfield Close Hatfield Hertfordshire AL10 8YG United Kingdom in data 14 feb 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    5 pagineMG01

    Nomina di Mark Birchall come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Lazenby come segretario in data 24 dic 2011

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Mark Birchall come segretario in data 24 dic 2011

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Lazenby come amministratore in data 24 dic 2011

    2 pagineTM01

    Nomina di Mark Birchall come amministratore in data 24 dic 2011

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB in data 25 nov 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 28 feb 2011

    75 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    21 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2011

    Stato del capitale al 17 giu 2011

    • Capitale: GBP 3,370,735
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Simon Mark Ashton il 23 mag 2011

    3 pagineCH01

    legacy

    10 pagineMG01

    Cessazione della carica di Graham Partridge come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Graham Partridge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Partridge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Hamley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Lazenby come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di ABBEYCREST PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIRCHALL, Mark
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Segretario
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    165887370001
    ASHTON, Simon Mark
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Amministratore
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish49915710004
    BIRCHALL, Mark Jason
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Amministratore
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritish70139540002
    CARPIN, Sarah Anne
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United KingdomBritish151677450001
    CHEESEBROUGH, Albert
    Arkendale House
    14 Rossett Gardens
    HG2 9PP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arkendale House
    14 Rossett Gardens
    HG2 9PP Harrogate
    North Yorkshire
    British25015550001
    DAVENPORT, Kathryn Anne
    Thorpe Park
    LS15 8GB Colton Leeds
    4100 Park Approach
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8GB Colton Leeds
    4100 Park Approach
    West Yorkshire
    EnglandBritish104948570002
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Segretario
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    154936310001
    PARTRIDGE, Graham Derek
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    British104567930001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    British190689780001
    BENSON, Kerry Michael
    81 High Ash Avenue
    LS17 8RX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    81 High Ash Avenue
    LS17 8RX Leeds
    West Yorkshire
    British37167930005
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Amministratore
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    British138964960001
    DEAR, Christopher Joseph
    946 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    946 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    British47542010001
    FEATHERSTONE, John Robson
    The Old Vicarage
    Bishop Monkton
    HG3 3QQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Bishop Monkton
    HG3 3QQ Harrogate
    North Yorkshire
    British2550160003
    HAMLEY, Nicholas Peter
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    EnglandBritish126433050002
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish138472720001
    LEVER, Michael Neville
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish12573190001
    MARCALL, Raymond George
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish3977340001
    PARTRIDGE, Graham Derek
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Orchard Gardens Weaverham
    CW8 3GZ Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish104567930001
    PETERSON, Carl Ian
    The Pound
    WV15 5JZ Worfield
    Shropshire
    Amministratore
    The Pound
    WV15 5JZ Worfield
    Shropshire
    British46002060001
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113293590001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish190689780001

    ABBEYCREST PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 02 feb 2012
    Consegnato il 07 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chrysus Holdco Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 mag 2011
    Consegnato il 06 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Moorgarth Property Investments Limited (Moorgarth)
    Transazioni
    • 06 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A share mortgage
    Creato il 02 lug 2009
    Consegnato il 10 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future shares and new rights; the mortgage secures the due and punctual payment of the secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Pledge and security agreement
    Creato il 22 giu 2009
    Consegnato il 06 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledged securities together with all cash dividends, stock dividends, interests, profits, redemptions, warrants subscription rights pledgor's records and the proceeds of all pledged property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 mar 2009
    Consegnato il 21 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Neville Lever
    Transazioni
    • 21 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the company's interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moorgath Investments Limited
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a peter rosenberg house 11-15 wilmington grove leeds and all other interests in any f/h or l/h property all fixtures and fittings and fixed plant and machinery its goodwill and its uncalled capital its book debts by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Peter rosenberg house 11/15 wilmington grove leeds t/n WYK585103 and ywe 66038,. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mag 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 giu 2001
    Consegnato il 19 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 1995
    Consegnato il 11 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land at site 4 sites 6 and 7 and site 11 barrack street light industrial estate sheepscar leeds west yorkshire together with any buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 03 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 mag 1991
    Consegnato il 17 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M678C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 lug 1990
    Consegnato il 24 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 dic 1986
    Consegnato il 12 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 ibm pc serial number BG5500038476 1 ibm proprieter xl serial number 580020825 (see form 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 1982
    Consegnato il 29 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H plot of land at sackville street and wilmington grove leeds 7, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ott 1979
    Consegnato il 26 ott 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ABBEYCREST PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 feb 2012Inizio dell'amministrazione
    04 feb 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Malcolm Titley
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praticante
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Andrew Poxon
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Praticante
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0