JARVIS TS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JARVIS TS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01412202 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JARVIS TS LIMITED?
- fabbricazione di altre apparecchiature elettriche (27900) / Industrie manifatturiere
Dove si trova JARVIS TS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o SECRETARIAT SERVICES LIMITED 17 MONKS BROOK INDUSTRIAL ESTATE School Close Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JARVIS TS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TECHSPAN SYSTEMS LIMITED | 11 feb 1993 | 11 feb 1993 |
| CARTNER ENGINEERING LIMITED | 28 giu 1990 | 28 giu 1990 |
| TECHSPAN ELECTRONICS LIMITED | 12 nov 1982 | 12 nov 1982 |
| VELWARD ELECTRONICS LIMITED | 29 gen 1979 | 29 gen 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS TS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JARVIS TS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS TS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Secretariat Services Limited il 12 lug 2011 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Adeyemi Asagba Akinlade il 12 lug 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Secretariat Services Limited il 16 mag 2011 | 3 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Meridian House the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW* in data 27 mag 2011 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2007 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di JARVIS TS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | c/o Directorate Services Limited Monks Brook Industrial Estate School Close Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh 17 England |
| 70053320013 | ||||||||||
| AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba | Amministratore | The Haven Woodview Close KT21 1HA Ashtead Surrey | England | British | 116740230002 | |||||||||
| LAIRD, Stuart Wilson | Amministratore | Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane Horton Heath SO50 7DF Eastleigh Hampshire | England | British | 60742240002 | |||||||||
| NOLAN, Richard | Segretario | 17 St Davids Road TN4 9JQ Tunbridge Wells Kent | Irish | 105084670001 | ||||||||||
| NYE, Ann Mary | Segretario | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Bucks | British | 17357120001 | ||||||||||
| MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Pickfords Wharf Clink Street SE1 9DG London | 32940220004 | |||||||||||
| BURTON, Ernest Walter | Amministratore | 15 Prince Consort Drive BR7 5SB Chislehurst Kent | British | 11389700001 | ||||||||||
| CHARRIER, Claude | Amministratore | 2 Bis Rue Joseph Thierry 37230 Luynes France | French | 42774510001 | ||||||||||
| DOYLE, Robert John | Amministratore | The Limes 112 Hewarth Green York North Yorkshire | British | 79420210002 | ||||||||||
| DUNN, John Nigel | Amministratore | 46 The Island Wraysbury Bucks | British | 23865780001 | ||||||||||
| DUPONT, Denis | Amministratore | 16 Rue Civiale 92380 Garches France | French | 98982530001 | ||||||||||
| GALLAGHER, Daniel Joseph | Amministratore | 9 Cavendish Meads Sunninghill SL5 9TB Ascot Berkshire | British And Irish | 49885010001 | ||||||||||
| GAY, Andrew | Amministratore | Bircham Dyson Bell 50 Broadway SW1H 0BL London | United Kingdom | British | 73774260004 | |||||||||
| GORDON, Ray | Amministratore | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | 102379260001 | ||||||||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Amministratore | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||||||
| KENDALL, Robert William | Amministratore | 44 Moreland Drive SL9 8BD Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 20374510001 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Amministratore | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| NYE, Ann Mary | Amministratore | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Bucks | British | 17357120001 | ||||||||||
| NYE, Richard Alfred | Amministratore | Beech Cottage Gorelands Lane HP8 4HQ Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 22791180001 | |||||||||
| PIRRET, Gordon Maxwell, Mr. | Amministratore | Bradwell Hall CM0 7HX Bradwell On Sea Essex | England | British | 30161610003 | |||||||||
| PLUMLEY, Xavier Alexander | Amministratore | Holly Cottage Hill Farm Road SL6 0HA Taplow Buckinghamshire | British | 51554040001 | ||||||||||
| RAFIN, Francois | Amministratore | L Aitre Des Gauthier 37210 Vernou S Brenne France | French | 42789710001 | ||||||||||
| SIMPSON, Terence Colin Frank | Amministratore | Homer Cottage Ipsden OX10 6QS Wallingford Oxfordshire | British | 34093540001 | ||||||||||
| TERRIS, Edward Ambrose | Amministratore | Twychelles Brindle Lane Forty Green HP9 1XT Beaconsfield Bucks | American | 20867310001 | ||||||||||
| WESTBROOK, Bernard Leslie | Amministratore | 4 Quantock Close Barton Seagrave NN15 6RR Kettering Northamptonshire | England | British | 51336870001 | |||||||||
| WILLIAMSON, Clive James Murray | Amministratore | 19 Padstow Drive Bramhall SK7 2HU Stockport Cheshire | British | 36771760001 | ||||||||||
| WORTHINGTON, Geoffrey John | Amministratore | Tudor House Blackwood Hill Farm Blackwood Hill ST9 9AH Endon Staffordshire | British | 85844580001 |
JARVIS TS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 01 feb 1995 Consegnato il 09 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 08 nov 1994 Consegnato il 22 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 30 june 1994 and the deed of variation | |
Brevi particolari Rental deposit of £35,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 lug 1989 Consegnato il 04 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 25 lug 1989 Consegnato il 04 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Hayder house, churchfield road, chalfornt-st-peter bucks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0