JARVIS TS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS TS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01412202
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS TS LIMITED?

    • fabbricazione di altre apparecchiature elettriche (27900) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova JARVIS TS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SECRETARIAT SERVICES LIMITED 17 MONKS BROOK INDUSTRIAL ESTATE
    School Close
    Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS TS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TECHSPAN SYSTEMS LIMITED11 feb 199311 feb 1993
    CARTNER ENGINEERING LIMITED28 giu 199028 giu 1990
    TECHSPAN ELECTRONICS LIMITED12 nov 198212 nov 1982
    VELWARD ELECTRONICS LIMITED29 gen 197929 gen 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS TS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JARVIS TS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS TS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ago 2013

    Stato del capitale al 09 ago 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Secretariat Services Limited il 12 lug 2011

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Adeyemi Asagba Akinlade il 12 lug 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Secretariat Services Limited il 16 mag 2011

    3 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Meridian House the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW* in data 27 mag 2011

    2 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    14 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di JARVIS TS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    c/o Directorate Services Limited
    Monks Brook Industrial Estate
    School Close Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    17
    England
    Segretario
    c/o Directorate Services Limited
    Monks Brook Industrial Estate
    School Close Chandlers Ford
    SO53 4RA Eastleigh
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03623281
    70053320013
    AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish116740230002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    NOLAN, Richard
    17 St Davids Road
    TN4 9JQ Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    17 St Davids Road
    TN4 9JQ Tunbridge Wells
    Kent
    Irish105084670001
    NYE, Ann Mary
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    Segretario
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    British17357120001
    MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    Segretario
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    32940220004
    BURTON, Ernest Walter
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    British11389700001
    CHARRIER, Claude
    2 Bis Rue Joseph Thierry
    37230 Luynes
    France
    Amministratore
    2 Bis Rue Joseph Thierry
    37230 Luynes
    France
    French42774510001
    DOYLE, Robert John
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    British79420210002
    DUNN, John Nigel
    46 The Island
    Wraysbury
    Bucks
    Amministratore
    46 The Island
    Wraysbury
    Bucks
    British23865780001
    DUPONT, Denis
    16 Rue Civiale
    92380 Garches
    France
    Amministratore
    16 Rue Civiale
    92380 Garches
    France
    French98982530001
    GALLAGHER, Daniel Joseph
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British And Irish49885010001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Amministratore
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritish73774260004
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    British102379260001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    NYE, Ann Mary
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    Amministratore
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Bucks
    British17357120001
    NYE, Richard Alfred
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Beech Cottage
    Gorelands Lane
    HP8 4HQ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish22791180001
    PIRRET, Gordon Maxwell, Mr.
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    Amministratore
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    EnglandBritish30161610003
    PLUMLEY, Xavier Alexander
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    British51554040001
    RAFIN, Francois
    L Aitre Des Gauthier
    37210 Vernou S Brenne
    France
    Amministratore
    L Aitre Des Gauthier
    37210 Vernou S Brenne
    France
    French42789710001
    SIMPSON, Terence Colin Frank
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    British34093540001
    TERRIS, Edward Ambrose
    Twychelles Brindle Lane
    Forty Green
    HP9 1XT Beaconsfield
    Bucks
    Amministratore
    Twychelles Brindle Lane
    Forty Green
    HP9 1XT Beaconsfield
    Bucks
    American20867310001
    WESTBROOK, Bernard Leslie
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish51336870001
    WILLIAMSON, Clive James Murray
    19 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    19 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    British36771760001
    WORTHINGTON, Geoffrey John
    Tudor House Blackwood Hill Farm
    Blackwood Hill
    ST9 9AH Endon
    Staffordshire
    Amministratore
    Tudor House Blackwood Hill Farm
    Blackwood Hill
    ST9 9AH Endon
    Staffordshire
    British85844580001

    JARVIS TS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 01 feb 1995
    Consegnato il 09 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 08 nov 1994
    Consegnato il 22 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 30 june 1994 and the deed of variation
    Brevi particolari
    Rental deposit of £35,000.
    Persone aventi diritto
    • Anne Mary Nye
    • Richard Alfred Nye
    • And Clive Percy Brooks
    • As Trustees of the Techspan Executive Small Self Administered Pension Scheme
    Transazioni
    • 22 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 1989
    Consegnato il 04 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 lug 1989
    Consegnato il 04 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hayder house, churchfield road, chalfornt-st-peter bucks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0