HEY (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEY (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01414745
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEY (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HEY (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEY (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEY SOFT DRINKS (U.K.) COMPANY LIMITED31 dic 198131 dic 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEY (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HEY (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HEY (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR

    2 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 dic 2014

    Stato del capitale al 18 dic 2014

    • Capitale: GBP 39,554
    SH01

    Cessazione della carica di Sunita Kaushal come segretario in data 29 lug 2014

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2013

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2013

    Stato del capitale al 17 dic 2013

    • Capitale: GBP 39,554
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* in data 27 ago 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di David Caldecott come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 01 lug 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Colin Elliot come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Gareth Caldecott il 18 dic 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 nov 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 05 set 2012

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Maxwell Coppel il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sunita Kaushal il 05 dic 2011

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* in data 05 dic 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di HEY (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Segretario
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Segretario
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158956040001
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BREARLEY, John Richard
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    British1575980001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    EnglandBritish73603940004
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    LISTER, Steven Bernard Lewis
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    Amministratore
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    British10137610001
    LONGDEN, John David
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish40890250001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    Amministratore
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    MCEVOY, John James
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish48091070001
    PARKINSON, Joseph Edward
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    Amministratore
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    United KingdomBritish4553470004
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    Amministratore
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SINGLETON, Paul James
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    British79357110001
    SPIEGELBERG, Anthony William Assheton
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish24626450001
    WHITE, Christopher Geoffrey
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    British58547200001

    HEY (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third supplemental trust deed
    Creato il 16 set 1998
    Consegnato il 01 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee the principal of and interest on the stock, being £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 of the greenalls group PLC and any further debenture stock of the greenalls group PLC created or issued pursuant to clause 3 of the principal trust deed, and all other monies intended to be secured by the principal trust deed dated 5 june 1991, any deed expressed to be supplemental thereto and any other deed or instrument conferring rights on the chargee executed or entered into pursuant to the principal trust deed or any deed supplemental thereto
    Brevi particolari
    The undertaking and all the property and assets present and future wherever situated (including any uncalled capital) of the company by way of first floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 01 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 16 set 1998
    Consegnato il 24 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent.(formerly 10 1/4 per cent) debenture stock 2017 (repayable on 23RD june 2017 or such earlier date as the security constituted by the trust deed the supplemental trust deed and the second supplemental trust deed becomes enforceable and the trustee determines or becomes bound to enforce the same) and of any moneys intended to be secured by the second supplemental trust deed
    Brevi particolari
    First floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1991
    Consegnato il 08 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land k/as depot mangham road barbot hall industrial estate rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1990
    Consegnato il 28 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold lands being depot,mangham road,barbot hall industrial,rotherham,south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1989
    Consegnato il 07 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Estate right title or interest (if any) or in a plot of land situate on the east side of skinner lane pontefract west yorkshire including beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1989
    Consegnato il 07 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings situate off bondgate,knottingley road and atkinson lane. Pontefract t/n wyk 339842 and plot of land situate off bondgate,knottingley road including interest in property or in the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 giu 1989
    Consegnato il 12 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land in barrys lane scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 1989
    Consegnato il 19 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Two freehold plots of land one situate between westfield road and holm flatt street in parkgate rotherham with the depot and offices erected thereon or on some part thereof and theother situate some short distance to the north east and also being in westgage with the buildings erected thereon or on some part thereof and used as a garage and store.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and building at spawd bone lane,knottingley,west yorkshire.t/no.wyk 21390 and part of t/no.wyk 427817.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at carnaby road bridlington T.no. Hs 1667.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings off station road,ushaw moor,county durham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings situate at skinner lane pontefract west yorkshire T.no wyk 20616.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 apr 1989
    Consegnato il 11 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 set 1988
    Consegnato il 08 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings spawd bone lanes knottingley,west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1988
    Consegnato il 10 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a on being land and buildings on the south side of lancaster road carnaby bridlington humberside t/n H.S. 1667 registered at H.M. land registry.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 nov 1987
    Consegnato il 01 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings on the east side of skinner lane, pontefract, west yorkshire title no wyk 20616.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The right title or interest of hey soft drinks (UK) company limited of and in a plot of land situate on the east side ofskenner lane, pontefract, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0