O I E SERVICES LIMITED

O I E SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàO I E SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01418001
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di O I E SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività delle agenzie di collocamento (78109) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova O I E SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    361-366 Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di O I E SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OPTIMA INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED07 dic 200107 dic 2001
    INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED24 ott 200124 ott 2001
    DIETSMANN MORGAN MOORE LIMITED31 dic 199831 dic 1998
    DIETSMANN (U.K.) LIMITED01 set 198201 set 1982
    MAC FELLOW LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    METVENUS LIMITED08 mag 197908 mag 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di O I E SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per O I E SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 apr 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 lug 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a 361-366 Buckingham Avenue Slough SL1 4LU in data 19 gen 2018

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Murray Jamieson Crane il 15 dic 2017

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Adam Powell come segretario in data 15 dic 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Murray Jamieson Crane come segretario in data 15 dic 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di John Ritchie Morrison come amministratore in data 15 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Florin Ianul come amministratore in data 15 giu 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 lug 2016

    17 pagineAA

    Nomina di Florin Ianul come amministratore in data 31 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Adam David Powell come amministratore in data 31 mar 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard John Paddison come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    23 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di O I E SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARNE, Murray Jamieson
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    Segretario
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    241237780002
    DONATIELLO, John
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    Amministratore
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    United StatesAmerican202354100001
    MORRISON, John Ritchie
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    Amministratore
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish236416530001
    POWELL, Adam David
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    Amministratore
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    United KingdomBritish229623250001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Segretario
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    British16917220001
    KROMBEEN, Leendert
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    Segretario
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    British7875650001
    POWELL, Adam
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Segretario
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    202356300001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    PETERKINS SERVICES LIMITED
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Segretario
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC184957
    154002830001
    BUCHANAN, George
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    Amministratore
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    ScotlandBritish44846630001
    CAVANAGH, Mark James
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Amministratore
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    United KingdomBritish43031460003
    CAVANAGH, Victoria
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Amministratore
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    ScotlandBritish159055800001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    EnglandBritish16917220001
    DELPECH, Pierre
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    Amministratore
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    French75213150001
    IANUL, Florin
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Amministratore
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    RomaniaRomanian229632930001
    KUTEMANN, Peter Renhart Gunnar
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Amministratore
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Dutch40690770002
    MAIN, Michael Robert
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish109530520001
    PADDISON, Richard John
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Amministratore
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    EnglandBritish63501590001
    RICHMOND, Robert Campbell Connor
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1009910001
    THAIN, Walter
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    Amministratore
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    British78371700001
    VAN DEN BERGE, Johan Herman Bernhard
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Amministratore
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Dutch75269810001
    VELTMAN, Willem Jan Petrus
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Amministratore
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Dutch25005180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di O I E SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    John Crane Group Ltd
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    06 apr 2016
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione05137825
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    O I E SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 mag 2015
    Consegnato il 11 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchase debts and floating charge on bank proceeds of debts
    Creato il 08 ott 2001
    Consegnato il 12 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the invoice discounting agreement or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge (1) all receivables purchased or purported to be purchased by the security holder from the company pursuant to a discounting agreement between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason (2) all other debts of the company and (3) the benefit of all guarantees indemnities, instruments and securities given to or held by the company in relation to any such receivable or other debt and the right to other records and documents on or by which any such receivable or other debt is recorded or evidenced 3 (1) fixed equitable charge all purchased debts and the other debts etc (2) floating charge such of the monies received etc.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 04 ott 2001
    Consegnato il 18 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from searosa limited to the chargee and dietsmann holding (cyprus) limited under the terms of a loan and security agreement of even date
    Brevi particolari
    The whole property (including uncalled capital) property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Dietsmann N.V.
    Transazioni
    • 18 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of offset.
    Creato il 24 apr 1992
    Consegnato il 11 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from linbide (G.B.)limited /and or dietsmann management services limited on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of the bank of scotland in the name of dietsmann (U.K.) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland .
    Transazioni
    • 11 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of contract monies
    Creato il 05 ott 1990
    Consegnato il 16 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights arising from contract no. C/45985/89/AO2 for ship manning of the msv stadive between shell UK limited (shell UK exploration and production) & dietsmann (UK) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charge
    Creato il 12 set 1990
    Consegnato il 21 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of. Offset
    Creato il 06 ago 1990
    Consegnato il 27 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dietsmann management systems limitedunder the terms of the charge.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of dietsmann (UK) LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of assignment
    Creato il 28 set 1983
    Consegnato il 18 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies due to dietsmann (UK) limited under the contract no c/42196/83/OA7 between dietsmann (UK) limited and shell (U.K.) limited.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez.
    Transazioni
    • 18 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    O I E SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    27 mag 2008Data della riunione per approvare il CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Mark Draine
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire
    Praticante
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0