KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED

KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKEITH SHARP PHARMACIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01418891
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEITH SHARP PHARMACY LIMITED05 feb 198205 feb 1982
    STAMPONEM LIMITED10 mag 197910 mag 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Increase of share capital from £100 to £69,082 25/11/2011
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 nov 2011

    • Capitale: GBP 69,082
    4 pagineSH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr William Shepherd come amministratore in data 01 ago 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Smerdon come amministratore in data 01 ago 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Jennifer Anne Brierley il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishChartered Accountant120451550002
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    SHARP, Lesley Joy
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    Segretario
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    British62700930001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    COUTURIER, Christophe
    4 Clopton House
    Clopton Road
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Clopton House
    Clopton Road
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    FrenchDirector51642250003
    DUNBAR, Dawn Marcia
    41 Glenville Road
    BH10 5DD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    41 Glenville Road
    BH10 5DD Bournemouth
    Dorset
    BritishBuyer15292220001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    BritishFinance Director39644740002
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector8991780003
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    BritishBusiness Development31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissCompany Director43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GermanyChief Finance Officer62107000001
    SANDERS, Alan Christopher
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    Amministratore
    17 Hollytrees
    GU13 0NL Church Crookham
    Hampshire
    BritishRetail Director46616760001
    SHARP, Keith Edward
    13 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    13 Alyth Road
    BH3 7DF Bournemouth
    Dorset
    BritishPharmacist15292230001
    SHARP, Lesley Joy
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Blissford
    SP6 2JH Fordingbridge
    Hampshire
    BritishSecretary62700930001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    SMITH, Graham Richard
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    BritishCompany Director15292210001
    SMITH, Graham Richard
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    6 Stour Road
    BH8 8SY Bournemouth
    Dorset
    BritishPharmacist15292210001
    TROUGHTON, John Mervyn
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Frolic House Woodlands Court
    Watford Village
    NN6 7XW Northampton
    Northamptonshire
    BritishBusiness Development1192800003
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant122881190001

    KEITH SHARP PHARMACIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mag 1994
    Consegnato il 02 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1994
    Consegnato il 01 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 448 kinson road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1994
    Consegnato il 01 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 446 kinson road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1994
    Consegnato il 01 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 1555/7 wimborne road bournemouth dorset & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1994
    Consegnato il 01 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 444 kinson road bournemouth dorset t/no DT123746 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 03 mag 1994
    Consegnato il 09 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 51 kinson road bournemouth dorset t/no DT147721 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1987
    Consegnato il 13 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    446, kinson road, bournemouth, dorset.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1985
    Consegnato il 16 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13, queens road, westbourne, bournemouth dorset.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 1984
    Consegnato il 19 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0