KEENPAC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKEENPAC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01418926
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KEENPAC LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KEENPAC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KEENPAC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEENPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    KEEPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED10 mag 197910 mag 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di KEENPAC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KEENPAC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2016

    Stato del capitale al 26 feb 2016

    • Capitale: GBP 23,776
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2015

    Stato del capitale al 04 mar 2015

    • Capitale: GBP 23,776
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Nicholas Hussey come amministratore in data 03 nov 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Brian Michael May come amministratore in data 03 nov 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew James Ball come amministratore in data 03 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lindsay Alexander Wilkie come amministratore in data 03 nov 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helen Ruth Cockerham come amministratore in data 03 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Varie

    Section 519
    3 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2014

    Stato del capitale al 14 apr 2014

    • Capitale: GBP 23,776
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Mooney come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nancy Lester come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Helen Ruth Cockerham come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Lindsay Alexander Wilkie come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KEENPAC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Segretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    BALL, Andrew James
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish95118620004
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish28010290009
    MAY, Brian Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish49698960004
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Segretario
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Segretario
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    British21883690003
    BRADSHAW, Glynn Laurence
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Warren Hill
    Newtown Linford
    LE6 0AL Leicester
    Bedch Tree Cottage
    Leicestershire
    British131211250001
    BUDGE, Charles Paul
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Chandlers
    Lower Ham Lane Elstead
    GU8 6HQ Godalming
    Surrey
    EnglandBritish49031660003
    COCKERHAM, Helen Ruth
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    Meridian Business Park
    LE19 1WH Leicester
    Keenpac
    United Kingdom
    EnglandBritish172707800001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Amministratore
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    JOHNSON, Alexander Kitson
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    Amministratore
    Lillington Road
    CV32 6LN Leamington Spa
    134
    Warwickshire
    United KingdomEnglish216172110001
    LESTER, Nancy Emma Sophia
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish67008510002
    LOCKYER, Robert Peter
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    26 Elm Tree Road
    Cosby
    LE9 1SR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish109919510002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    UkBritish21883690003
    SLAVIN, Desmond
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    Amministratore
    259 Markfield Lane
    LE67 9PR Markfield
    Leicestershire
    EnglandBritish45492620001
    THOMPSON, Darren
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    9 Eastgate
    Hallaton
    LE16 8UB Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish109919520001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WALTERS, Andrew
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Home Farm
    Braybrooke Road
    LE16 8PF Dingley Market Harborough
    Leicestershire
    British118764310001
    WELLS, Anthony Bernard
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    Amministratore
    28 Forest Rise
    Oadby
    LE2 4FH Leicester
    British44612560001
    WILKIE, Lindsay Alexander
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish300728840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KEENPAC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Yorse No. 2 Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    KEENPAC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share pledge
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the keenpac shares and all its rights, title, interests and benefits in and to the keenpac shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac north america limited , a new york corporation owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold property known as plot 28B phase ii meridian business park braunstone blaby leicestershire title number LT299854. The freehold property known as 127 scudamore road leicester title number LT229493. The leasehold property known as 24A meridian business park braunstone blaby leicestershire.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in It's Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 14 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,630,000 being the amount of a loan advanced to the company plus a maximum of £5,350,000 due or to become due from the company to the chargee under a multi option facility granted to the company and other companies within its group together with interest and costs for the benefit of the bank which are accepted by the company
    Brevi particolari
    The whole of the shares (the "shares") in keenpac france sarl owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of quotas to secure own liabilities
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 14 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ordinary quotas to the par value of lit 50,000,000 in keenpac italia S.R.L. plus all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The life policy (policy taken by the company over the life of glynn laurence bradshaw in the sum of £1,000,000 with a period of cover 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The life policy (policy taken by the company over the life of andrew walters in the sum of £500,000 with a period of cover of 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of stocks and shares
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    110 common stock shares in keenpac north america limited and 7000 ordinary shares in keenpac hong kong limited (the "securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    127 scudamore rd,leicestershire; t/no LT229493. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as plot 28 b phase ii meridian business park,braunstone,blaby,leicestershire; t/no LT299854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 dic 1997
    Consegnato il 31 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a plot 28B phase 2 meridian business park braunstone leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee which have been advanced by way of loan credit or for the provision of letters of credit and the like included (but not limited to) advances made by virtue of a credit facility agreement dated 25 january 1995
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex Limited
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All principal sums at any time advanced to the company by the chargees pursuant to an agreement dated 25 january 1995
    Brevi particolari
    All that f/h land and property k/as 127 scudamore road,leicester.t/no.LT229493.
    Persone aventi diritto
    • Overseas Sales Limited
    • British Markitex LTD
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 19 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 25TH july 1994
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring or discounting deed dated 11TH february 1994 and all book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 17 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    127 scudamore road leicester leicestershire title no LT229493.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 1994
    Consegnato il 02 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 apr 1991
    Consegnato il 18 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any monies standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC (please see form 395. reg m 519.C.).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 mag 1990
    Consegnato il 15 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 127 scudamore road leicester and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 02 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge on book and other debts present & future & proceeds thereof (see 395 M595C for details).
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawre Receuable Financing Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 07 lug 1988
    Consegnato il 19 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable property & assts in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 17 gen 1985
    Consegnato il 02 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Book debts.
    Persone aventi diritto
    • H & H Factors Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 nov 1983
    Consegnato il 08 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/hand l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 lug 1981
    Consegnato il 23 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys from time to time held to thecredit of the company by national westminster bank on any current deposit and/or other account which the company may now and/or hereafter have with that west bank or held by that west bank on an account earmarked re the company and/or underany deposit receipt.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0