KEENPAC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KEENPAC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01418926 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KEENPAC LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KEENPAC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KEENPAC LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| KEENPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| KEEPAC POLYTHENE SUPPLIES LIMITED | 10 mag 1979 | 10 mag 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KEENPAC LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per KEENPAC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Nicholas Hussey come amministratore in data 03 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Brian Michael May come amministratore in data 03 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew James Ball come amministratore in data 03 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lindsay Alexander Wilkie come amministratore in data 03 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Ruth Cockerham come amministratore in data 03 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Varie Section 519 | 3 pagine | MISC | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Mooney come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nancy Lester come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Helen Ruth Cockerham come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Lindsay Alexander Wilkie come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KEENPAC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSSEY, Paul Nicholas | Segretario | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc | British | 28010290009 | ||||||
| BALL, Andrew James | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | 95118620004 | |||||
| HUSSEY, Paul Nicholas | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | 28010290009 | |||||
| MAY, Brian Michael | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | 49698960004 | |||||
| BRADSHAW, Glynn Laurence | Segretario | 34 Warren Hill Newtown Linford LE6 0AL Leicester Bedch Tree Cottage Leicestershire | British | 131211250001 | ||||||
| MUIR, David Scott | Segretario | 29 Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | British | 21883690003 | ||||||
| BRADSHAW, Glynn Laurence | Amministratore | 34 Warren Hill Newtown Linford LE6 0AL Leicester Bedch Tree Cottage Leicestershire | British | 131211250001 | ||||||
| BUDGE, Charles Paul | Amministratore | Chandlers Lower Ham Lane Elstead GU8 6HQ Godalming Surrey | England | British | 49031660003 | |||||
| COCKERHAM, Helen Ruth | Amministratore | Centurion Way Meridian Business Park LE19 1WH Leicester Keenpac United Kingdom | England | British | 172707800001 | |||||
| CUNNINGHAM, James Alan | Amministratore | 115 Broomwood Road SW11 6JU London | England | British | 51864840002 | |||||
| JOHNSON, Alexander Kitson | Amministratore | Lillington Road CV32 6LN Leamington Spa 134 Warwickshire | United Kingdom | English | 216172110001 | |||||
| LESTER, Nancy Emma Sophia | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | England | British | 67008510002 | |||||
| LOCKYER, Robert Peter | Amministratore | 26 Elm Tree Road Cosby LE9 1SR Leicester Leicestershire | England | British | 109919510002 | |||||
| MOONEY, Andrew John | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 34345860002 | |||||
| MUIR, David Scott | Amministratore | 29 Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | Uk | British | 21883690003 | |||||
| SLAVIN, Desmond | Amministratore | 259 Markfield Lane LE67 9PR Markfield Leicestershire | England | British | 45492620001 | |||||
| THOMPSON, Darren | Amministratore | 9 Eastgate Hallaton LE16 8UB Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 109919520001 | |||||
| WALTERS, Andrew | Amministratore | Home Farm Braybrooke Road LE16 8PF Dingley Market Harborough Leicestershire | British | 118764310001 | ||||||
| WALTERS, Andrew | Amministratore | Home Farm Braybrooke Road LE16 8PF Dingley Market Harborough Leicestershire | British | 118764310001 | ||||||
| WELLS, Anthony Bernard | Amministratore | 28 Forest Rise Oadby LE2 4FH Leicester | British | 44612560001 | ||||||
| WILKIE, Lindsay Alexander | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 300728840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KEENPAC LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorse No. 2 Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7JT London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
KEENPAC LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Share pledge | Creato il 21 mag 2002 Consegnato il 01 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the keenpac shares and all its rights, title, interests and benefits in and to the keenpac shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge agreement | Creato il 21 mag 2002 Consegnato il 01 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The whole of the shares (the "shares") in keenpac north america limited , a new york corporation owned by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 mag 2002 Consegnato il 01 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The freehold property known as plot 28B phase ii meridian business park braunstone blaby leicestershire title number LT299854. The freehold property known as 127 scudamore road leicester title number LT229493. The leasehold property known as 24A meridian business park braunstone blaby leicestershire.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mag 2002 Consegnato il 01 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge agreement | Creato il 12 mag 1999 Consegnato il 14 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,630,000 being the amount of a loan advanced to the company plus a maximum of £5,350,000 due or to become due from the company to the chargee under a multi option facility granted to the company and other companies within its group together with interest and costs for the benefit of the bank which are accepted by the company | |
Brevi particolari The whole of the shares (the "shares") in keenpac france sarl owned by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge of quotas to secure own liabilities | Creato il 12 mag 1999 Consegnato il 14 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Ordinary quotas to the par value of lit 50,000,000 in keenpac italia S.R.L. plus all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 03 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The life policy (policy taken by the company over the life of glynn laurence bradshaw in the sum of £1,000,000 with a period of cover 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 03 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The life policy (policy taken by the company over the life of andrew walters in the sum of £500,000 with a period of cover of 5 years) (the "policy"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of stocks and shares | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 03 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 110 common stock shares in keenpac north america limited and 7000 ordinary shares in keenpac hong kong limited (the "securities"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 17 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge containing fixed and floating charges | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 17 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 127 scudamore rd,leicestershire; t/no LT229493. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge containing fixed and floating charges | Creato il 10 feb 1999 Consegnato il 17 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as plot 28 b phase ii meridian business park,braunstone,blaby,leicestershire; t/no LT299854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 17 dic 1997 Consegnato il 31 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property k/a plot 28B phase 2 meridian business park braunstone leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 gen 1995 Consegnato il 27 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee which have been advanced by way of loan credit or for the provision of letters of credit and the like included (but not limited to) advances made by virtue of a credit facility agreement dated 25 january 1995 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 25 gen 1995 Consegnato il 27 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All principal sums at any time advanced to the company by the chargees pursuant to an agreement dated 25 january 1995 | |
Brevi particolari All that f/h land and property k/as 127 scudamore road,leicester.t/no.LT229493. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 11 ago 1994 Consegnato il 19 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 25TH july 1994 | |
Brevi particolari Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring or discounting deed dated 11TH february 1994 and all book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 ago 1994 Consegnato il 17 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 127 scudamore road leicester leicestershire title no LT229493. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 lug 1994 Consegnato il 02 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 15 apr 1991 Consegnato il 18 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any monies standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC (please see form 395. reg m 519.C.). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 11 mag 1990 Consegnato il 15 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 127 scudamore road leicester and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 31 gen 1989 Consegnato il 02 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari First fixed charge on book and other debts present & future & proceeds thereof (see 395 M595C for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 07 lug 1988 Consegnato il 19 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including heritable property & assts in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 17 gen 1985 Consegnato il 02 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 nov 1983 Consegnato il 08 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all f/hand l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 08 lug 1981 Consegnato il 23 lug 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys from time to time held to thecredit of the company by national westminster bank on any current deposit and/or other account which the company may now and/or hereafter have with that west bank or held by that west bank on an account earmarked re the company and/or underany deposit receipt. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0