CLOUDSURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLOUDSURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01420136
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLOUDSURE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CLOUDSURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLOUDSURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SERVO COMPUTER SERVICES LIMITED18 ott 200618 ott 2006
    SERVO COMPUTER SERVICES PLC31 dic 198031 dic 1980
    DOWERBOND LIMITED16 mag 197916 mag 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLOUDSURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per CLOUDSURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    7 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Lewis Mcglennon il 30 nov 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Neil Philip Thompson come amministratore in data 12 nov 2021

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed servo computer services LIMITED\certificate issued on 04/11/21
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 nov 2021

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 nov 2021

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    9 pagineAA

    Notifica di Daisy Telecoms Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Daisy It Managed Services Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2019

    1 paginePSC07

    Modifica dei dettagli di Daisy It Managed Services Limited come persona con controllo significativo il 29 apr 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House, Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 29 apr 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CLOUDSURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGLENNON, David Lewis
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish181536600002
    SMITH, Stephen Alan
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish161471940001
    THOMPSON, Neil Philip
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    EnglandBritish158049040002
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Segretario
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British57302660001
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Segretario
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    199438630001
    STOKES, Reeta
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    173997430001
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    179707420001
    WRAGG, Keith
    80 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    80 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    Derbyshire
    British50768630002
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish294355310001
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    BILLING, Roger Stephen
    Belgrave House
    Belgrave Drive
    S10 3LQ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Belgrave House
    Belgrave Drive
    S10 3LQ Sheffield
    South Yorkshire
    British66939500001
    BODILL, Timothy John
    Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton-On-Trent
    16
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton-On-Trent
    16
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140942610001
    BURROWS, Nigel
    Greystone Head
    Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard
    HG4 3RU Ripon
    N Yorks
    Amministratore
    Greystone Head
    Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard
    HG4 3RU Ripon
    N Yorks
    British35683460001
    CLUTTON, Steven
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish158222570001
    COURTLEY, David John
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141213480001
    FARROW, Matthew James
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    EnglandBritish194105960001
    HOWARTH, Mark Edward John
    8 Parsons Grove
    Denby Village
    DE5 8PY Ripley
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Parsons Grove
    Denby Village
    DE5 8PY Ripley
    Derbyshire
    British79403870001
    JACKSON, Peter Daniel
    The Orchard Main Street
    Heath
    S44 5SA Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    The Orchard Main Street
    Heath
    S44 5SA Chesterfield
    Derbyshire
    British23515580002
    JONES, David Emrys
    Biggin House
    Biggin By Hulland
    DE6 3FJ Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Biggin House
    Biggin By Hulland
    DE6 3FJ Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandEnglish211566200001
    LLOYD, Neil Anthony
    7 Kenwyn Road
    SW20 8TR London
    Amministratore
    7 Kenwyn Road
    SW20 8TR London
    EnglandBritish181988860001
    LOCKWOOD, Robert John Harry
    37 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    British111070890001
    MARKE, Nathan Richard
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish194292450001
    MARTIN, William Thomas
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish57302660001
    MOAKES, Philip
    Hall Cliffe Cottage
    Back Lane, Warslow
    SK17 0JL Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    Hall Cliffe Cottage
    Back Lane, Warslow
    SK17 0JL Buxton
    Derbyshire
    EnglandBritish94198370001
    MULLER, Neil Keith
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    EnglandBritish252490400001
    PODMORE, Victor Gerald
    12 Middlefield Drive
    Great Finborough
    IP14 3AH Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    12 Middlefield Drive
    Great Finborough
    IP14 3AH Stowmarket
    Suffolk
    British15200080001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish178585250001
    ROBINSON, Nicholas John
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish54873290006
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Amministratore
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    SMITH, William Joe
    Belstead Old Rectory
    Copdock
    IP8 3JS Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Belstead Old Rectory
    Copdock
    IP8 3JS Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish20327120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLOUDSURE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    12 lug 2019
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6977942
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    06 apr 2016
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01983540
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CLOUDSURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 ott 2001
    Consegnato il 07 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ago 1994
    Consegnato il 05 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture
    Creato il 19 ago 1994
    Consegnato il 05 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 06 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Servo house bakewell road darley dale matlock derbyshire t/nody 246529.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Servo house, littlemoor, eckington, sheffield, N.E.derbyshire. T/no.DY151593 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1987
    Consegnato il 02 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £210,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H the drill hall, littlemoor, echington, derbyshire. Title no dy 151593.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 02 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 nov 1982
    Consegnato il 09 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 gen 1981
    Consegnato il 14 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 6/10 sheffield road, dronfield, derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0