CLOUDSURE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CLOUDSURE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01420136 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CLOUDSURE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CLOUDSURE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CLOUDSURE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SERVO COMPUTER SERVICES LIMITED | 18 ott 2006 | 18 ott 2006 |
| SERVO COMPUTER SERVICES PLC | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| DOWERBOND LIMITED | 16 mag 1979 | 16 mag 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CLOUDSURE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per CLOUDSURE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 7 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Lewis Mcglennon il 30 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Philip Thompson come amministratore in data 12 nov 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed servo computer services LIMITED\certificate issued on 04/11/21 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Daisy Telecoms Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Daisy It Managed Services Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Daisy It Managed Services Limited come persona con controllo significativo il 29 apr 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Daisy House, Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 29 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nathan Richard Marke come amministratore in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lewis Mcglennon come segretario in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CLOUDSURE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Amministratore | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 181536600002 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Amministratore | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| THOMPSON, Neil Philip | Amministratore | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | England | British | 158049040002 | |||||
| BADGER, Nicholas | Segretario | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| MARTIN, William Thomas | Segretario | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Segretario | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | 199438630001 | |||||||
| STOKES, Reeta | Segretario | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173997430001 | |||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Segretario | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179707420001 | |||||||
| WRAGG, Keith | Segretario | 80 Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield Derbyshire | British | 50768630002 | ||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Amministratore | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BADGER, Nicholas | Amministratore | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BADGER, Nicholas | Amministratore | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Amministratore | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| BILLING, Roger Stephen | Amministratore | Belgrave House Belgrave Drive S10 3LQ Sheffield South Yorkshire | British | 66939500001 | ||||||
| BODILL, Timothy John | Amministratore | Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton-On-Trent 16 Staffordshire United Kingdom | England | British | 140942610001 | |||||
| BURROWS, Nigel | Amministratore | Greystone Head Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard HG4 3RU Ripon N Yorks | British | 35683460001 | ||||||
| CLUTTON, Steven | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 158222570001 | |||||
| COURTLEY, David John | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 141213480001 | |||||
| FARROW, Matthew James | Amministratore | 34 Lychgate Close LE10 2ES Burbage Leicestershire | England | British | 194105960001 | |||||
| HOWARTH, Mark Edward John | Amministratore | 8 Parsons Grove Denby Village DE5 8PY Ripley Derbyshire | British | 79403870001 | ||||||
| JACKSON, Peter Daniel | Amministratore | The Orchard Main Street Heath S44 5SA Chesterfield Derbyshire | British | 23515580002 | ||||||
| JONES, David Emrys | Amministratore | Biggin House Biggin By Hulland DE6 3FJ Ashbourne Derbyshire | England | English | 211566200001 | |||||
| LLOYD, Neil Anthony | Amministratore | 7 Kenwyn Road SW20 8TR London | England | British | 181988860001 | |||||
| LOCKWOOD, Robert John Harry | Amministratore | 37 The Mount Wrenthorpe WF2 0NZ Wakefield West Yorkshire | British | 111070890001 | ||||||
| MARKE, Nathan Richard | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MARTIN, William Thomas | Amministratore | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 57302660001 | |||||
| MOAKES, Philip | Amministratore | Hall Cliffe Cottage Back Lane, Warslow SK17 0JL Buxton Derbyshire | England | British | 94198370001 | |||||
| MULLER, Neil Keith | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | England | British | 252490400001 | |||||
| PODMORE, Victor Gerald | Amministratore | 12 Middlefield Drive Great Finborough IP14 3AH Stowmarket Suffolk | British | 15200080001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| ROBINSON, Nicholas John | Amministratore | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | 54873290006 | |||||
| ROBINSON, Nicholas | Amministratore | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| ROBINSON, Nicholas | Amministratore | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Amministratore | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||
| SMITH, William Joe | Amministratore | Belstead Old Rectory Copdock IP8 3JS Ipswich Suffolk | England | British | 20327120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CLOUDSURE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 12 lug 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Daisy It Managed Services Limited | 06 apr 2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CLOUDSURE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 25 ott 2001 Consegnato il 07 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 ago 1994 Consegnato il 05 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture | Creato il 19 ago 1994 Consegnato il 05 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture of even date | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 06 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Servo house bakewell road darley dale matlock derbyshire t/nody 246529. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 31 mar 1992 Consegnato il 13 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Servo house, littlemoor, eckington, sheffield, N.E.derbyshire. T/no.DY151593 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 ago 1987 Consegnato il 02 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £210,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari F/H the drill hall, littlemoor, echington, derbyshire. Title no dy 151593. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 nov 1982 Consegnato il 09 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 07 gen 1981 Consegnato il 14 gen 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold 6/10 sheffield road, dronfield, derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0