MCSA GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MCSA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01421913 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MCSA GROUP LIMITED?
- Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
- Attività di gestione delle strutture informatiche (62030) / Informazione e comunicazione
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova MCSA GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Greenwich 6 Mitre Passage Greenwich Peninsula SE10 0ER London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MCSA GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MAINDEC COMPUTER SOLUTIONS LIMITED | 13 mag 2002 | 13 mag 2002 |
| MAINDEC COMPUTER ENGINEERING LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| MAINDEC COMPUTERS LIMITED | 22 mag 1979 | 22 mag 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MCSA GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MCSA GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 23 dic 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2019 | 40 pagine | AA | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Reynolds Porter Chamberlain Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1AA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Reynolds Porter Chamberlain Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1AA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Maindec House Holtspur Lane Wooburn Green Bucks, HP10 0AB a Greenwich 6 Mitre Passage Greenwich Peninsula London SE10 0ER in data 12 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 27 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 mar 2019
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Scott Robert Timms come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Roger Jeffrey Timms come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Roger Timms come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Jeffrey Timms come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Stella May il 29 mar 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione di Roger Jeffrey Timms come persona con controllo significativo il 29 mar 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Cessazione di Brenda Joyce Timms come persona con controllo significativo il 29 mar 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Park Place Technologies Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Reginald Hodge come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MCSA GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLINGER, Elizabeth Ann | Amministratore | Landerbrook Drive Mayfield Heights 5910 Ohio 44124 United States | United States | American | 276704390001 | |||||
| MAY, Stella Rachelle, Ms. | Amministratore | Stanier Road SN11 9PX Calne 6 England | United States | American | 257114710001 | |||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Segretario | Holtspur Lane Wooburn Green HP10 0AB High Wycombe Maindec House Buckinghamshire England | 202629460001 | |||||||
| PATEMAN, Alan Leslie Charles | Segretario | 59 Kimpton Close HP2 7PW Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 82718160001 | ||||||
| TIMMS, Roger Jeffrey | Segretario | Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead High Gables Hertfordshire United Kingdom | British | 2274480001 | ||||||
| BROOKE-WILLIAMS, Sasha Louise | Amministratore | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244019070001 | |||||
| CLARE, Brian | Amministratore | 12 Crabtree Lane HP3 9EG Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 22784430001 | ||||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Amministratore | 77 Grove Road HP23 5PB Tring Hertfordshire | England | British | 82678530001 | |||||
| HODGE, Mark Reginald | Amministratore | 38 Chesterfield Crescent Wing LU7 0TW Buckinghamshire | United Kingdom | British | 9536030003 | |||||
| PATEMAN, Alan Leslie Charles | Amministratore | 59 Kimpton Close HP2 7PW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 82718160001 | |||||
| TIMMS, Brenda Joyce | Amministratore | High Gables Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 40499630001 | |||||
| TIMMS, Christopher Jeffrey | Amministratore | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244018980001 | |||||
| TIMMS, Paul Roger | Amministratore | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | United Kingdom | British | 150237780001 | |||||
| TIMMS, Roger Jeffrey | Amministratore | High Gables Felden Lane Felden HP3 0BB Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 2274480001 | |||||
| TIMMS, Scott Robert | Amministratore | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | England | British | 244018950001 | |||||
| WHITE, Cherry Olive | Amministratore | Kimble House Southend Common RG9 6JP Henley On Thames Oxfordshire | British | 40499660001 | ||||||
| WHITE, Richard | Amministratore | Garden Cottage Winkfield Lane Maidens Green SL4 4QS Windsor | England | British | 19513930004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MCSA GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Place Technologies Limited | 29 mar 2019 | Stanier Road SN11 9PX Calne 6 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mrs Brenda Joyce Timms | 08 mar 2019 | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Roger Jeffrey Timms | 06 apr 2016 | Maindec House Holtspur Lane HP10 0AB Wooburn Green Bucks, | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MCSA GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 23 dic 1997 Consegnato il 07 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 apr 1989 Consegnato il 13 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari And heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 14 dic 1987 Consegnato il 29 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a maindee house, abbey barn rd, high wycombe inc. Goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 ago 1984 Consegnato il 17 ago 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property mayfield house kingsmead business centre abbeybarn road wycombe marsh high wycombe buckinghamshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 lug 1984 Consegnato il 20 lug 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see doc M29. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 apr 1982 Consegnato il 30 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital tog. With all fixtures incl trade fixtures fixed plant & machinery. (See doc M28). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0