SHIELDTECH PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHIELDTECH PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01423125
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHIELDTECH PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova SHIELDTECH PLC?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHIELDTECH PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BASE GROUP PLC27 giu 200227 giu 2002
    DIGITAL SPORT PLC29 nov 200029 nov 2000
    FERRUM HOLDINGS PLC24 nov 198924 nov 1989
    FLOYD ENERGY PLC16 mag 198816 mag 1988
    FLOYD OIL PARTICIPATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY25 mag 197925 mag 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHIELDTECH PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SHIELDTECH PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 20 apr 2011

    18 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 20 apr 2011

    17 pagine2.35B

    Cessazione della carica di Pommy Sarwal come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Grundy come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul Grundy come amministratore

    2 pagineTM01

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    9 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    2 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    42 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 5 Chesford Grange Woolston Warrington WA1 4RQ United Kingdom in data 04 nov 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2010 con elenco di azionisti in blocco

    18 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ago 2010

    Stato del capitale al 09 ago 2010

    • Capitale: GBP 9,009,694
    SH01

    Cessazione della carica di Robert Denton come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2009

    46 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Denton come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Paul Grundy come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Paul Grundy come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Denton come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    68 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Appointing as a director/investment the circular 22/06/2009
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine395

    Chi sono gli amministratori di SHIELDTECH PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    O`NEILL, Anthony Arthur
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Aran Heights
    HP8 4DZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British58776190001
    POVEY, Keith, Sir
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    Amministratore
    Rufford House
    5 High Street
    LN5 0QX Brant Broughton
    Lincolnshire
    British123375790001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish8610650001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Segretario
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    British250279270001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Segretario
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    145996590001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Segretario
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    British128648070001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Segretario
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Segretario
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    AITKEN, Robin Douglas
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    Amministratore
    Uphill
    Combe Hay
    BA2 7EG Bath
    Avon
    British62740310002
    AKERS, John Michael Anthony
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    White Walls Farley Lane
    Romsley
    B62 0LG Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritish17792380001
    ANGEL, Leon
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    2 Laurimel Close
    HA7 2SU Stanmore
    Middlesex
    British14283520001
    BAARTMANS, Kees-Jan
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Amministratore
    Brasschaatselei 10
    FOREIGN 2950 Kapellen
    Belgium
    Dutch28166930001
    BARKER, Crispin Jonathan
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    Amministratore
    Socknersh Manor Fontridge Lane
    TN19 7DE Etchingham
    East Sussex
    British23728980001
    BRADSHAW, Adrian Effland
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    Amministratore
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish74991310001
    BRIDGE, Peter John
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    Amministratore
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    United KingdomBritish54098960002
    CARTER, John Henry
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Chantry 51 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British15186400001
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Amministratore
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DENTON, Robert William
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Telham Cottage
    Cottesmore Road Ashwell
    LE15 7LJ Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish250279270001
    FRIER, Gavin Austin
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Ceadr Grove House
    Dirleton
    EH39 5DR North Berwick
    East Lothian
    British692610004
    GARNER, Marshall Kenneth
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    3 Woodside Drive
    Barnt Green
    B45 8XT Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish52313820002
    GOURLAY, John Malcolm
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Great Gables
    Bosbury
    HR8 1QA Ledbury
    Herefordshire
    British574590001
    GRUNDY, Paul
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    Amministratore
    Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    74
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    HATTON, John Leonard
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    7 Merricks Close
    DY12 2PF Bewdley
    Worcestershire
    British17792410001
    HOPKINSON, Glenn
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    10 Walnut Grove
    SO22 5HR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish76865910002
    HORNER, Rupert Howard Milton
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Home Farm House 33 High Street
    Chipstead
    TN13 2RW Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish42919770001
    HUME, James Douglas Howden
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Drimard 22 East Lennox Drive
    G84 9JD Helensburgh
    Dunbartonshire
    British738610001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Amministratore
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    United KingdomBritish128648070001
    KENNEDY, Simon Mark
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    Amministratore
    106 Warwick Road Alkrington
    Middleton
    M24 1HL Manchester
    British60141130001
    KITTOE, Stephen Maurice
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    75 Knaves Hill
    LU7 2SE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British692590009
    LENSEN, John
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Amministratore
    Basaltdyk 51
    4706DR Roosendaal
    The Netherlands
    Dutch38326960001
    MCCAUGHEY, Paul Trevor
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    Amministratore
    Flat 14 Tiffany Heights
    59 Standen Road
    SW18 5TF London
    British76385200002
    MILLER, Simon Edward Callum
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    Amministratore
    Cleish Castle
    KY13 0LW Cleish
    Kinross Shire
    ScotlandBritish176036600001
    ROUND, Richard Calvin
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    Amministratore
    5 Craigowmill
    Milnathort
    KY13 0RT Kinross Perth
    British108158250001
    SARWAL, Pommy Prodaman Kumar
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    28 Atwood Avenue
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritish103609350001
    SMITH, Gary
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    10 Farquhar Road
    Edgbaston
    B15 3RB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish94244890001

    SHIELDTECH PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 giu 2009
    Consegnato il 01 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bruce Gordan Stephen Jenkins and Derek James
    Transazioni
    • 01 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2009
    Consegnato il 25 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 08 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 13 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as mech tool housemains works whessoe road darlington county durham title number DU14506 and DU18947. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 07 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property as fabrication shop situate at riverview industrial estate off dodsworth street darlington durham title numbers DU160790 DU160904 DU181997 and DU126993. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 dic 1993
    Consegnato il 08 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as amended
    Brevi particolari
    The tenants interest uder a lease between london & edinburgh trust (scotland) limited and the cmpany dated 13/3/and 29/4/92. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 dic 1993
    Consegnato il 08 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/12/93 and a mortgage debenture dated 3/12/93 as may be amended
    Brevi particolari
    The tenants interest in a lease between the city of aberdeen district council and offshore drilling supplies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the east side of hoylake road bottesford humberside glanford t/no HS185215 with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a west side of rotherham road rotherham south yorkshire t/no syk 251481 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of park lane basford nottingham nottinghamshire t/nos NT285394 and NT211704 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank the full benefit of all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of whessoe road darlington durham t/no DU14506 DU18947 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business the full benefitof all licences and together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a river view industrial estate dodsworth street darlington durham t/no's du 181997 DU160904 DU160790 DU126993 and the proceeds of sale thereof with the assigns the goodwill of the business to the bank full benefit f all licences together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 13 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Brevi particolari
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian together with the buildings and other erections thereon k/a 57 melville street. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 13 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under theterms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 30/11/93
    Brevi particolari
    All and whole that area of ground lying to the north west of melville street edinburgh county of midlothian. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 nov 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1/7/93 as amended from time to time in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Brevi particolari
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescent east tullos industrial aberdeen in the city of aberdeen extending to 3.45 acres or thereby.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 nov 1993
    Consegnato il 09 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 1/7/93 in respect of a standard security which was presented for registration in scotland on the 24/11/93
    Brevi particolari
    All and whole the area of ground lying on the south east side of greenbank crescnt east tullos industrial estate aberdeen in the city of aberdeen and county foresaid extending to 3.45 acres or thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 1993
    Consegnato il 17 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property on north east side of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 1993
    Consegnato il 10 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Brevi particolari
    F/H land on west of park lane new basford nottingham part t/n nt 285394.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 1993
    Consegnato il 10 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 01/07/93
    Brevi particolari
    F/H land on north east of dodsworth street darlington durham part of riverview industrial estate t/nsdu 160790,du 160904,du 181997.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 lug 1993
    Consegnato il 15 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 set 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1993
    Consegnato il 15 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 set 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHIELDTECH PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ott 2010Inizio dell'amministrazione
    20 apr 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0