SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01425948 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
- Ricerche di mercato e sondaggi d'opinione pubblica (73200) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 100 St. James Road NN5 5LF Northampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| Q FIELD MARKETING SOLUTIONS LIMITED | 07 giu 2016 | 07 giu 2016 |
| NOP GLOBAL LIMITED | 04 ago 2015 | 04 ago 2015 |
| GFK NOP FIELD MARKETING SERVICES LIMITED | 30 set 2005 | 30 set 2005 |
| NOP FIELD MARKETING SERVICES LIMITED | 03 mar 2004 | 03 mar 2004 |
| INTERNATIONAL HEALTH SURVEYS LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| CRUMPSPARK LIMITED | 06 giu 1979 | 06 giu 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 10 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 King Edward Street Oxford OX1 4HL England a 100 st. James Road Northampton NN5 5LF in data 15 mar 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19 | 11 pagine | 4.20 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014259480002, creata il 06 dic 2016 | 23 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 nov 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Louise Holliday come amministratore in data 27 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Freeths Llp Cumberland Court 80 Mount Street Nottingham Nottinghamshire NG1 6HH | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Freeths Llp Cumberland Court 80 Mount Street Nottingham Nottinghamshire NG1 6HH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014259480001, creata il 21 lug 2016 | 26 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Martin come amministratore in data 03 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Steven John Mayhew come amministratore in data 03 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John White come amministratore in data 03 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Pfann come amministratore in data 03 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ivar Reimer Michaelsen come amministratore in data 03 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthias Krauss come amministratore in data 03 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Legal Dept. Level 18 25 Canada Square Canary Wharf London E14 5LQ a 8 King Edward Street Oxford OX1 4HL in data 06 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alexander Pfann come amministratore in data 12 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Anne-Marie Horgan Gfk Nop Field Marketing Services Ltd Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UL England a C/O Legal Dept. Level 18 25 Canada Square Canary Wharf London E14 5LQ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLIDAY, Alan James | Amministratore | St. James Road NN5 5LF Northampton 100 | England | British | 116590650001 | |||||
| HOLLIDAY, Louise | Amministratore | St. James Road NN5 5LF Northampton 100 | United Kingdom | British | 218505610001 | |||||
| MARTIN, James | Amministratore | St. James Road NN5 5LF Northampton 100 | United Kingdom | British | 209021710001 | |||||
| MAYHEW, Steven John | Amministratore | St. James Road NN5 5LF Northampton 100 | England | British | 197901260001 | |||||
| BLETSO, Bryan Edward | Segretario | 11 Broomfield Park RH4 3QQ Westcott Surrey | British | 50582160004 | ||||||
| GLASS, David Selig | Segretario | 13 Denewood EN5 1LX New Barnet Hertfordshire | British | 37146920001 | ||||||
| RHODES, John Eric | Segretario | 40 West Hill Park N6 6ND London | British | 38761670001 | ||||||
| SHAY, Ian Lawton | Segretario | 24 Les Bois High Road Layer De La Haye CO2 0EX Colchester Essex | British | 9138100001 | ||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
| JAMESON, Richard David | Amministratore | c/o Legal Dept. 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Level 18 London England | United Kingdom | British | 68704460001 | |||||
| KELLY, Paul Dominic | Amministratore | 29 Fullbrooks Avenue KT4 7PE Worcester Park Surrey | England | British | 85834800002 | |||||
| KELLY, Paul Dominic | Amministratore | 12b Idmiston Road KT4 7ST Worcester Park Surrey | British | 85834800001 | ||||||
| KRAUSS, Matthias | Amministratore | King Edward Street OX1 4HL Oxford 8 England | England | German | 132354700002 | |||||
| MACFARLANE, Phyllis Joan | Amministratore | 245 Blackfriars Road SE1 9UL London Ludgate House | England | British | 12026780001 | |||||
| MACFARLANE, Phyllis Joan | Amministratore | Flat 4 12 Lindfield Gardens NW3 6PU London | England | British | 12026780001 | |||||
| MICHAELSEN, Ivar Reimer | Amministratore | King Edward Street OX1 4HL Oxford 8 England | Denmark | Danish | 201793740001 | |||||
| MOLLOY, Christopher Andrew | Amministratore | 22 Cleveland Square W2 London | British | 12026790001 | ||||||
| PFANN, Alexander | Amministratore | King Edward Street OX1 4HL Oxford 8 England | United Kingdom | German | 208315540001 | |||||
| SHAY, Ian Lawton | Amministratore | 24 Les Bois High Road Layer De La Haye CO2 0EX Colchester Essex | British | 9138100001 | ||||||
| SNOW, Christopher | Amministratore | Orchard House Widmoor HP10 0JG Wooburn Common Buckinghamshire | England | British | 55898080001 | |||||
| SPEDDING, Michael | Amministratore | Flat 1 120 Goldhurst Terrace NW6 London | British | 18762230001 | ||||||
| STOCKER, Ivor Charles | Amministratore | Hazlemere 29 Rayleigh Road Wimbledon SW19 3RE London | United Kingdom | British | 27664840001 | |||||
| VAN DER WERF, Bernhard Eberhard | Amministratore | c/o Legal Dept. 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Level 18 London England | United Kingdom | Dutch | 197556840001 | |||||
| WHITE, Christopher John | Amministratore | King Edward Street OX1 4HL Oxford 8 England | England | British | 21327980004 | |||||
| WINTER, Keith Michael | Amministratore | 8 Roseneath Road SW11 6AH London | British | 90087370001 | ||||||
| WOODLOCK, Simon John | Amministratore | 39 Westfield Road KT6 4EL Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 69948110002 | |||||
| WOODLOCK, Simon John | Amministratore | 3 Hollycroft Close CR2 7FE Croydon Surrey | British | 69948110001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Alan James Holliday | 03 giu 2016 | St. James Road NN5 5LF Northampton 100 | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 06 dic 2016 Consegnato il 08 dic 2016 | In corso | ||
Breve descrizione A fixed and floating charge over all assets. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 21 lug 2016 Consegnato il 21 lug 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SPARK FIELD SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0