ESNT GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàESNT GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01427647
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ESNT GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ESNT GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ESNT GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLONDALKIN GROUP (U.K.) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    CLONDALKIN MILLS GROUP (U.K.) LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    CROUCHKARN LIMITED11 giu 197911 giu 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di ESNT GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ESNT GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Request for strike off 03/11/2017
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reques for strike off 03/11/2017
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Strike off of company 03/11/2017
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Leonard Mcneil Kirk come amministratore in data 09 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hugh Alexander Ross come amministratore in data 14 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Rayner come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Iain Philip Percival come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Stato del capitale al 21 nov 2016

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 05/09/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 014276470005 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 014276470004 in pieno

    4 pagineMR04

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed clondalkin group (U.K.) LIMITED\certificate issued on 18/02/16
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 feb 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2015

    Stato del capitale al 27 ott 2015

    • Capitale: GBP 12,200,102
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Jon Michael Green il 12 giu 2015

    3 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di ESNT GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Jon Michael
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    199015330001
    PERCIVAL, Iain Philip
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    EnglandBritish175638680001
    RAYNER, Peter Alexander
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish187386230002
    BERGIN, Liam Gerard
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Segretario
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Irish36702870001
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Segretario
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    British74242880001
    CARMICHAEL, James
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    British88088510001
    CUNNINGHAM, Gordon Batten
    Todrigs Mill
    KA2 9AD Earlston
    Kilmarnock
    Amministratore
    Todrigs Mill
    KA2 9AD Earlston
    Kilmarnock
    British54674800002
    HAWORTH, John
    9 Sycamore Court
    NP2 0DA Blackwood
    Gwent
    Amministratore
    9 Sycamore Court
    NP2 0DA Blackwood
    Gwent
    British33041010001
    INCHLEY, Graham Haydock
    The Corner House
    Cosby
    LE9 1RQ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Corner House
    Cosby
    LE9 1RQ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish73374510001
    JANSEN, Michel Francis
    c/o C\O Clondalkin \ Ap Burt
    Royal Portbury Dock
    Portbury
    BS20 7XP Bristol
    First Avenue
    England
    Amministratore
    c/o C\O Clondalkin \ Ap Burt
    Royal Portbury Dock
    Portbury
    BS20 7XP Bristol
    First Avenue
    England
    NetherlandsDutch183967330001
    KIRK, Leonard Mcneil
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish299758440001
    LUND, Henry
    325 Chestnut Street Suite 909
    Philadelphia Pa
    19106 Usa
    Amministratore
    325 Chestnut Street Suite 909
    Philadelphia Pa
    19106 Usa
    Irish45449190001
    MCDERMOTT, Norbert
    2002 Lantern Lane
    Oreland 19097
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    2002 Lantern Lane
    Oreland 19097
    Pennsylvania
    Usa
    Irish59125180001
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Amministratore
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    EnglandBritish74242880001
    O'NEILL, Colman
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    IrelandIrish45448600001
    ROSS, Hugh Alexander
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish246975310001
    SCALLY, Derek
    13 Woodbine Road
    Blackrock
    IRISH Dublin
    Ireland
    Amministratore
    13 Woodbine Road
    Blackrock
    IRISH Dublin
    Ireland
    Irish55404130001
    TANYAR, Feyzoullah Yalkin
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    British33720300001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ESNT GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05023353
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ESNT GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 10 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 10 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transazioni
    • 10 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 12 lug 2007
    Consegnato il 30 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 30 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 29 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all of the real property, by way of first fixed charge all estates or interests in any real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all of the charged deposits, all investments and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C. (The Security Agent) for Itself and on Behalf of the Securedcreditors
    Transazioni
    • 29 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second stage debenture
    Creato il 23 nov 1999
    Consegnato il 07 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to secured parties (or any of them) wheter collectively or individually under the finance doucments (or any of them) and under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0