INPOST DISTRIBUTION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INPOST DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01430241 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi (46760) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Moray House 23-35 Great Titchfield Street W1W 7PA London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 06 ago 2001 | 06 ago 2001 |
| JOHN MENZIES DISTRIBUTION LIMITED | 28 gen 1998 | 28 gen 1998 |
| NEWSRIDERS LIMITED | 29 lug 1985 | 29 lug 1985 |
| GOLDEN ACORN PUBLISHING COMPANY LIMITED(THE) | 15 giu 1979 | 15 giu 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 28 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 19 mag 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 02 giu 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 19 mag 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Michael Brian Rouse come amministratore in data 27 nov 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Oliver Kuschel come amministratore in data 26 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 dic 2024 | 66 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA England a Moray House 23-35 Great Titchfield Street London W1W 7PA in data 25 giu 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed menzies distribution LIMITED\certificate issued on 25/06/25 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit E, Twelvetrees Business Park Twelvetrees Crescent London E3 3JG England a Moray House, 23-25 Great Titchfield Street London W1W 7PA in data 25 giu 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Neil Kuschel come amministratore in data 15 ott 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gregory John Michael come amministratore in data 15 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2023 | 48 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 014302410013 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 62 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gregory John Michael il 07 set 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014302410013, creata il 01 ago 2022 | 26 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 18 pagine | MA | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014302410012, creata il 22 lug 2022 | 72 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 01 gen 2022 | 60 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 014302410011 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 014302410008 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 014302410008 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 014302410004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCOURT, Paul Raymond Patrick | Amministratore | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | Scotland | British | 183278190001 | |||||
| ROUSE, Michael Brian | Amministratore | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 343342430001 | |||||
| ANDERSON, Charles Adair | Segretario | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | British | 44142970001 | ||||||
| GEDDES, John Francis Alexander | Segretario | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | British | 103057020004 | ||||||
| KIRKWOOD, George | Segretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| MULHOLLAND, Eric | Segretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 152434850001 | |||||||
| MULHOLLAND, Eric | Segretario | 81 Auchingane EH10 7HU Edinburgh | British | 984680001 | ||||||
| TURNBULL, David Alistair | Segretario | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | 166629600001 | |||||||
| ANDERSON, Charles Adair | Amministratore | Ravensheugh TD7 5LS Selkirk | United Kingdom | British | 44142970001 | |||||
| BELL, Paula | Amministratore | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland | Scotland | British | 116712890002 | |||||
| BENNETT, James Douglas Scott | Amministratore | The Well House 3 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh | British | 365550003 | ||||||
| BLACK, Forsyth Rutherford | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 188546240002 | |||||
| BLAND, Catherine Mary | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 153744340002 | |||||
| BOYLE, Thomas | Amministratore | 26 Dreghorn Loan EH13 0DE Edinburgh | Irish | 107652260002 | ||||||
| CALLAGHAN, Iain Mills | Amministratore | 10 Kings Cramond Gamekeepers Road EH4 6RL Edinburgh Midlothian | British | 145895140001 | ||||||
| CASSIE, Mark Stephen | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 161586010001 | |||||
| COOKE, David Michael | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | England | British | 146398580001 | |||||
| COYLE, Francis John | Amministratore | 1 Struan Place KY11 1NF Inverkeithing Fife | Scotland | British | 54147130001 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DOLLMAN, Paul Bernard | Amministratore | 36 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh | Scotland | British | 1230000002 | |||||
| DYSON, Jane Allison | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 103858670002 | |||||
| JENKINSON, Dermot Julian | Amministratore | Mersington House Greenlaw TD10 6UL Duns Berwickshire | Scotland | British | 681840002 | |||||
| KIRKWOOD, George | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | British | 107652330001 | ||||||
| KUSCHEL, Neil Oliver | Amministratore | Great Titchfield Street W1W 7PA London Moray House 23-35 England | England | British | 328820160001 | |||||
| MACDONALD, Patrick James | Amministratore | 30 Royal Terrace EH7 5AH Edinburgh | Scotland | British | 90055380002 | |||||
| MACKAY, David James | Amministratore | 4 East Harbour Road KY11 3EA Charlestown Fife | Scotland | British | 681850002 | |||||
| MCINTOSH, David Dennis | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 85826730002 | |||||
| MELLON, Christina | Amministratore | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Scotland | British | 139986280001 | |||||
| MICHAEL, Gregory John | Amministratore | 2 Redheughs Rigg South Gyle EH12 9DQ Edinburgh Verdant Scotland | England | British | 221854770002 | |||||
| MITCHELL, Alexander | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | United Kingdom | British | 139998290001 | |||||
| MORTON, David Emerson | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | British | 13180890002 | |||||
| NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon | Amministratore | Easter Dunbarnie Bridge Of Earn PH2 9ED Perth Perthshire | British | 21482560001 | ||||||
| SMITH, Martyn Robert | Amministratore | 12/2 Mcdonald Road EH7 4LZ Edinburgh | British | 65137160006 | ||||||
| SPEIRS, David William Ogden | Amministratore | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Middlesex 4 England England | Scotland | Scottish | 129856460001 | |||||
| WARD, John | Amministratore | 9a Mossgreen KY4 8BU Crossgates Fife | British | 84407440002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INPOST DISTRIBUTION LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzies Distribution Holdings Limited | 04 set 2018 | Whitehall Quay LS1 4BF Leeds 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| John Menzies Plc | 06 apr 2016 | Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh 2 Scotland Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Menzies Group Holdings Limited | 06 apr 2016 | World Business Centre Heathrow, Newall Road London Heathrow Airport TW6 2SF Hounslow 2 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0