KUNICK (109) LIMITED

KUNICK (109) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKUNICK (109) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01434201
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KUNICK (109) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KUNICK (109) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KUNICK (109) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAMESTEC LEISURE LIMITED02 dic 200202 dic 2002
    KUNICK LEISURE LIMITED09 feb 199609 feb 1996
    MUSIC HIRE GROUP LIMITED31 dic 198031 dic 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di KUNICK (109) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KUNICK (109) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KUNICK (109) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagine4.72

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 apr 2013

    29 pagine2.24B

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    25 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* in data 15 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2012

    Stato del capitale al 20 ago 2012

    • Capitale: GBP 90,496,864.88
    SH01

    Cessazione della carica di Christopher Butler come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Brown come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Leisure Connection Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* in data 20 ago 2012

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Horsforth Mills Low Lane Horsforth LS18 4ER* in data 03 ago 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 01 ott 2011

    31 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Butler come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Brown come amministratore

    2 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed gamestec leisure LIMITED\certificate issued on 25/07/12
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name25 lug 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 19 lug 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    legacy

    5 pagineMG01

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di KUNICK (109) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    BAILEY, Geoffrey Raw
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    British49609920001
    BROWN, Andrew Paul
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    Amministratore
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    United KingdomBritish126397230001
    BUTLER, Christopher Michael
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    Amministratore
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    EnglandBritish146447120001
    COPPIN, Alan Charles
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82808900001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    EVANS, Wayne David
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    United KingdomBritish118359700001
    HODKIN, David Arthur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    Amministratore
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    United KingdomBritish40702370002
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Amministratore
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JOHNSON, Alex
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    Amministratore
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    EnglandBritish213648130001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    LLOYD, Derek Thomas
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    Amministratore
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    EnglandEnglish98695040001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    NIELSEN, Rolf
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50980130003
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Richard Stephen
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    British54147940001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Amministratore
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    British809230004
    WALTERS, Philip Donald
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    Amministratore
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    United KingdomBritish78370620002
    WOOD, Russell Stephen
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    British64853900002

    KUNICK (109) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 13 mar 2012
    Consegnato il 21 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £43,750 plus vat.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Computacenter (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge of deposit
    Creato il 18 nov 2011
    Consegnato il 24 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £23,000 and all amounts in the future credited to account number 46214410 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge of deposit
    Creato il 07 apr 2011
    Consegnato il 12 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £177,255 and all amounts in the future credited to account number 46040943 with the bank. Note: the charge contains a covenant by the company that the company will not permit or create any mortgage charge or lien on the deposit or dispose of or assign the deposit.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 ott 2009
    Consegnato il 06 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £70793.75 and all sums paid to the landlord under the terms of the rent deposit deed see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Computacenter (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Bank account charge and receivables assignment
    Creato il 20 ago 2009
    Consegnato il 21 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged accounts and the bank balances, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 22 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the derivative assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse the Security Trustee
    Transazioni
    • 22 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 21 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch (Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002
    Creato il 09 feb 2004
    Consegnato il 25 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the newly acquired properties together with all buildings fixtures fixed plany and machinery, being all that f/h property known as the maltings wetmore road burton on trent t/n SF47581,the f/h property known as the old granary wetmore road burton on trent t/n SF4757750, the f/h property known as unit 51 hutton close, crowther industrial estate washington sunderland tyne & wear t/n TY202817.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 21 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1992
    Consegnato il 18 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a composite guarantee and debenture dated 12/10/92
    Brevi particolari
    F/H property near the railway station pewsey wilts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Banks
    Transazioni
    • 18 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the "debenture"
    Brevi particolari
    Land at automat house aqueduct road,blackburn,lancashire title number LA404853 see doc ref M554C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcand Each of the Banksin Its Capacity as Agent and Trustee for Itself
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 20 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the floating documents
    Brevi particolari
    Various properties as specified in from 395 reg: m 76.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plce Governor and Company of the Bank of Scotland).(For Itself National Westminster Bank PLC and Th
    Transazioni
    • 20 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 dic 1990
    Consegnato il 21 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the items of equipment described in the schedule attached to the charge (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 28 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second fixed charge on all bookdebts & other debts. (See doc M57 for full details,).
    Persone aventi diritto
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Floating charbge
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 28 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 23 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (1) l/h premises company a warehouse at yeadon near leeds. T/no - 227594 (2) l/h unit 1, the perivale new business centre, perivale, middx (see doc M54 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Release and debenture mortgage
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 23 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge supplemental to a chattel mortgage dated 9-3-82
    Brevi particolari
    All and singular us item or items of equipment described in the schedule to the charge which are described as the additional items in the charge.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 gen 1986
    Consegnato il 28 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/hold & l/hold properties as more fully described in doc M55 and continuation sheet attached. (See doc M55 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Release and further mortgage
    Creato il 25 lug 1985
    Consegnato il 29 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule to the deed together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Release and further charge
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 02 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82.
    Brevi particolari
    All the singular items of equipment listed on the schedule to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated) by midland bank bank PLC ("the chattel") (see schedule for details.).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Release and further mortgage
    Creato il 26 ott 1984
    Consegnato il 31 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due under a chattel mortgage 9.3.82 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule together with any other items or equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Release and further mortgage
    Creato il 29 giu 1984
    Consegnato il 04 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all moneys due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other items or item of equipment as may be designated by midland bank PLC ("the chattel").
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Release and further mortgage
    Creato il 15 mar 1984
    Consegnato il 16 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) from the company to the chargee or any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC (the chattel).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1984Registrazione di un'ipoteca

    KUNICK (109) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    03 apr 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    03 apr 2013Inizio della liquidazione
    04 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0