SEP PRESSTECH LIMITED

SEP PRESSTECH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSEP PRESSTECH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01445149
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SEP PRESSTECH LIMITED?

    • (2875) /

    Dove si trova SEP PRESSTECH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SEP PRESSTECH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    S.E.P. PRESSTECH LIMITED15 feb 199115 feb 1991
    MAURICE ENGINEERING LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    ACRONENG LIMITED22 ago 197922 ago 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di SEP PRESSTECH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per SEP PRESSTECH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2023

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2022

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2021

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2020

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2019

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2018

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2017

    14 pagine4.68

    Cessazione della carica di Michael Clifford Ball come segretario in data 09 gen 2017

    2 pagineTM02

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 25 feb 2016

    LRESEX

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 gen 2016

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 lug 2015

    3 pagine2.15

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order - replacement of administrator
    16 pagineLIQ MISC OC

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order - replacement of administrator
    31 pagineLIQ MISC OC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 gen 2015

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 lug 2014

    1 pagine2.15

    Indirizzo della sede legale modificato da * Rsm Tenon Recovery 11Th Floor 66 Chiltern Street London W1U 4JT* in data 14 mar 2014

    2 pagineAD01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 gen 2014

    2 pagine2.15

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:order of court appointing garry wallace lock and removing trevor john binyon as liquidators of the company
    31 pagineLIQ MISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 lug 2013

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 gen 2013

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 lug 2012

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 06 gen 2012

    2 pagine2.15

    Chi sono gli amministratori di SEP PRESSTECH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALL, Michael Clifford
    4 Unwin Crescent
    DY8 3UY Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    4 Unwin Crescent
    DY8 3UY Stourbridge
    West Midlands
    British46728510001
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Segretario
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    British1227500001
    AIKEN, William John, Mr.
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    55 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40553130001
    ALLEN, Julian David
    1218 Aldridge Road
    Great Barr
    B44 8PE Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    1218 Aldridge Road
    Great Barr
    B44 8PE Birmingham
    West Midlands
    BritishAccountant12509420005
    BAKER, David Arthur
    4 Betteridge Drive
    B76 1FN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 Betteridge Drive
    B76 1FN Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishEngineer12509430002
    BRANIGAN, Michael
    227 Beeches Road
    Great Barr
    B42 2QS Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    227 Beeches Road
    Great Barr
    B42 2QS Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector & General Manager29214150001
    CARTWRIGHT, Neil Richard
    264 Lode Lane
    B91 2HY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    264 Lode Lane
    B91 2HY Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant59209200001
    FORMBY, Paul Madders
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    BritishFinancial Consultant87104890001
    HOUGH, Stephen John
    29 Kurtus
    Dosthill
    B77 1NX Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    29 Kurtus
    Dosthill
    B77 1NX Tamworth
    Staffordshire
    EnglandEnglishProduction Engineer58073310001
    LAWTON, Brian Tony
    14232 Houghton
    Livonia
    Michigan
    48154
    Usa
    Amministratore
    14232 Houghton
    Livonia
    Michigan
    48154
    Usa
    AmericanDirector80990460001
    LEA, Geoffrey Charles
    150 East View Road
    Wylde Green
    B72 1LJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    150 East View Road
    Wylde Green
    B72 1LJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishEngineer12509410002
    LONG, David Brian
    30 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Amministratore
    30 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    BritishDirector40011570001
    MARLOW, Roben Mcdonald
    36 Burton Old Road West
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    36 Burton Old Road West
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishProduction Engineer38840730001
    PRICE, Peter John
    11 Tennyson Place
    St Neots
    PE19 3LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    11 Tennyson Place
    St Neots
    PE19 3LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishChartered Engineer9762590001
    WITHEY, Anthony James
    7 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    7 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishProduction Engineer49871060001

    SEP PRESSTECH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of debenture
    Creato il 02 mag 2000
    Consegnato il 11 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 11 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    All assets debenture
    Creato il 29 set 1995
    Consegnato il 30 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 14 mag 1992
    Consegnato il 19 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all uncalled capital goodwill all patents inventions trade markssee 395 285 c 19/5 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 dic 1989
    Consegnato il 09 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including book & otherdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 gen 1989
    Consegnato il 06 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 giu 1988
    Consegnato il 23 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 29 set 1987
    Consegnato il 12 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 set 1987
    Consegnato il 12 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 10 mag 1982
    Consegnato il 12 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 02 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 giu 1981
    Consegnato il 09 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 13 mar 1980
    Consegnato il 24 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1980Registrazione di un'ipoteca

    SEP PRESSTECH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 lug 2000Inizio dell'amministrazione
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter Dunn
    Horwath Clark Whitehill & Co
    Sherlock House
    W1U 6HE 7 Kenrick Place
    London
    Praticante
    Horwath Clark Whitehill & Co
    Sherlock House
    W1U 6HE 7 Kenrick Place
    London
    Simon Robert Thomas
    Tenon Recovery
    Arkwright House
    M3 2LF Parsonage Gardens
    Manchester
    Praticante
    Tenon Recovery
    Arkwright House
    M3 2LF Parsonage Gardens
    Manchester
    Trevor John Binyon
    66 Chiltern Street
    W1U 4JT London
    Praticante
    66 Chiltern Street
    W1U 4JT London
    Stanley Donald Burkett-Coltman
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Praticante
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Garry Wallace Lock
    Highfield Court
    Tollgate Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Praticante
    Highfield Court
    Tollgate Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Richard Patrick Brewer
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Matthew Robert Haw
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Peter James Hughes-Holland
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Buckinghamshire
    Praticante
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Buckinghamshire
    2
    DataTipo
    25 feb 2016Inizio della liquidazione
    26 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Patrick Brewer
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0