SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED

SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01446230
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    • Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TETRA INTERNATIONAL LIMITED26 mar 199826 mar 1998
    TETRA SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED31 ott 199731 ott 1997
    TETRA LIMITED17 gen 198917 gen 1989
    TETRA BUSINESS SYSTEMS LIMITED30 ago 197930 ago 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da North Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE13 9AA a 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH in data 05 gen 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 dic 2017

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 ago 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 14/08/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Victoria Louise Bradin il 01 ott 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Victoria Louise Bradin come amministratore in data 16 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brendan Peter Flattery come amministratore in data 16 set 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ago 2015

    Stato del capitale al 03 ago 2015

    • Capitale: GBP 650,750
    SH01

    Nomina di Mr Mark Parry come amministratore in data 18 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alastair John Mitchell come amministratore in data 18 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Parry come segretario in data 31 lug 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Louise Hall come segretario in data 31 lug 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2014

    Stato del capitale al 04 ago 2014

    • Capitale: GBP 650,750
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARRY, Mark
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Segretario
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    190499030001
    BRADIN, Victoria Louise
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North Park
    United Kingdom
    Amministratore
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North Park
    United Kingdom
    EnglandBritish214451730001
    PARRY, Mark
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Amministratore
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    United KingdomBritish198658460001
    BYRNE, Paul Bernard
    32 Castlebar Park
    Ealing
    W5 1BU London
    Segretario
    32 Castlebar Park
    Ealing
    W5 1BU London
    British1450630001
    HALL, Louise
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    Segretario
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    British77212940004
    JOHNSTON, Alistair James
    2 Syon Park Gardens
    TW7 5NB Isleworth
    Middlesex
    Segretario
    2 Syon Park Gardens
    TW7 5NB Isleworth
    Middlesex
    British115073570001
    NEEDHAM, Janet Susan
    Woodview
    Gregory Road
    SL2 3XL Hedgerley
    Buckinghamshire
    Segretario
    Woodview
    Gregory Road
    SL2 3XL Hedgerley
    Buckinghamshire
    British77105480001
    POYSER, David Charles
    4 Rose Hill
    RH4 2EG Dorking
    Surrey
    Segretario
    4 Rose Hill
    RH4 2EG Dorking
    Surrey
    British147187260001
    SCHOFIELD, Alan Donald
    1 Summerhill Avenue
    NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    1 Summerhill Avenue
    NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British115685980001
    STEINGOLD, Lawrence Gerald
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    Segretario
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    British96504890001
    BAILEY, Stephen Paul
    99 Chapman Square Parkside
    Wimbledon Common
    SW19 5QW London
    Amministratore
    99 Chapman Square Parkside
    Wimbledon Common
    SW19 5QW London
    British86511990001
    BREARLEY, John Richard
    39 Beverley Terrace
    Cullercoats
    NE30 4NU North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    39 Beverley Terrace
    Cullercoats
    NE30 4NU North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish114980350001
    BYRNE, Paul Bernard
    32 Castlebar Park
    Ealing
    W5 1BU London
    Amministratore
    32 Castlebar Park
    Ealing
    W5 1BU London
    British1450630001
    COOKE, Roderick William Cameron
    The Old Vicarage
    Long Crendon Road
    OX9 3AB Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Long Crendon Road
    OX9 3AB Thame
    Oxfordshire
    British1457260001
    CRITCHLOW, Robert Howard
    Weybourne Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Weybourne Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish48964050002
    DOWLING, Sean Francis
    Cranes Farm House
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Cranes Farm House
    East Garston
    RG16 7HU Newbury
    Berkshire
    Great BritainBritish1450640002
    FLATTERY, Brendan Peter
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    Amministratore
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    United KingdomBritish168203410001
    GASS, Andrew
    1 Ashdown Way
    Kingwood
    RG9 5WD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 Ashdown Way
    Kingwood
    RG9 5WD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish49358720003
    GEARY, Karen Mary
    The Coach House
    Sandhoe
    NE46 4LU Corbridge
    Northumberland
    Amministratore
    The Coach House
    Sandhoe
    NE46 4LU Corbridge
    Northumberland
    United KingdomBritish74821590001
    JOHNSTON, Alistair James
    2 Syon Park Gardens
    TW7 5NB Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    2 Syon Park Gardens
    TW7 5NB Isleworth
    Middlesex
    United KingdomBritish115073570001
    KINGSLAND, Frank Leonard
    8 Holsart Close
    KT20 5EJ Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    8 Holsart Close
    KT20 5EJ Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish67457890002
    MAY, Gavin Disney
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    Amministratore
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    EnglandBritish85874690001
    MCFARLAND, Adrienne Ann
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    Amministratore
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    United KingdomBritish125854290002
    MITCHELL, Alastair John
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    Amministratore
    North Park
    Newcastle Upon Tyne
    NE13 9AA Tyne & Wear
    United KingdomBritish79762180002
    RAY, Josephine
    14 Elmfield Gardens
    Gosforth
    NE3 4XB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    14 Elmfield Gardens
    Gosforth
    NE3 4XB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish117640490002
    SARAGOSSI, Mark
    3 Hurst Place
    HA6 2JS Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    3 Hurst Place
    HA6 2JS Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish36140510002
    SCHOFIELD, Alan Donald
    1 Summerhill Avenue
    NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Summerhill Avenue
    NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish115685980001
    SHERMAN, Steven Jay
    31 Chapel Square
    GU25 4SZ Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    31 Chapel Square
    GU25 4SZ Virginia Water
    Surrey
    British55547640001
    STEINGOLD, Lawrence Gerald
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    Amministratore
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    EnglandBritish96504890001
    THOMSON, Neil, Doctor
    Lochletter House
    Balnain
    IV63 6XW Drumnadrochit
    Inverness
    Amministratore
    Lochletter House
    Balnain
    IV63 6XW Drumnadrochit
    Inverness
    United KingdomBritish29859190002
    WHEATON, Paul James Michael
    6 Symondson Mews
    RG12 5TE Binfield
    Berkshire
    Amministratore
    6 Symondson Mews
    RG12 5TE Binfield
    Berkshire
    British7575390002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tetra Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    North Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tetra Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2498852
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 04 giu 1990
    Consegnato il 16 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company and/or rapidideo limited now k/a tetra holdings limited to the chargee under or pursuant to this debenture and/or the loan agreement and/or the guarantee as defined.
    Brevi particolari
    (See form 395-ref M776C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays International Limited(As Trustee for the Schroder UK Venture Fund 1).
    Transazioni
    • 16 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 25 mag 1990
    Consegnato il 11 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 22 giu 1989
    Consegnato il 27 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 apr 1988
    Consegnato il 21 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All bank debts both present and future, benefit of all rights relating thereof, debts and claim, copyrights patents, trademarks, inventions, design, know how and other intellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 12 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any monies now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC. And all interest now due or henceforth to become due in respect thereof. The schedule the accounts at lloyds bank PLC designated "lloyds bank PLC re tetra business systems LTD business call a/c; lloyds bank PLC re tetra business systems LTD extra interest a/c; lloyds bank PLC re tetra business systems LTD fixed term deposit".
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1987Registrazione di un'ipoteca

    SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 apr 2019Data di scioglimento
    07 dic 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp,
    8 Princes Parade,
    L3 1QH Liverpool.
    Praticante
    Kpmg Llp,
    8 Princes Parade,
    L3 1QH Liverpool.
    John David Thomas Milsom
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0