DECTON INVESTMENTS LIMITED

DECTON INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDECTON INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01447579
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENTNEY PROPERTY SERVICES LIMITED18 mag 198918 mag 1989
    HOLLYHOCK PROPERTIES LIMITED07 set 197907 set 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 nov 2011

    Stato del capitale al 22 nov 2011

    • Capitale: GBP 4,800
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Trevor Pass come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Charles Stephen Beal il 20 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Trevor Pass il 20 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per James Edward Lee il 20 nov 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2008

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2007

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2006

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di DECTON INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEE, James Edward
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    Segretario
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    BritishAccountant10085240001
    BEAL, Charles Stephen
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    Amministratore
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    UsaBritishCertified Accountant10085250004
    BEAL, Peggy
    30952 Via Mirador
    San Juan
    92675 Capistrano
    California
    Usa
    Segretario
    30952 Via Mirador
    San Juan
    92675 Capistrano
    California
    Usa
    British18655620006
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    Segretario
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    British10085240001
    SANDERSON, Barry
    8 Cornwall Road
    DN22 6SH Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    8 Cornwall Road
    DN22 6SH Retford
    Nottinghamshire
    BritishAccountant37791510001
    BEAL, Rodney
    26 Fernbank Drive
    Eckington
    S21 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    26 Fernbank Drive
    Eckington
    S21 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer71868590001
    BRADLEY, Brian
    98 Heath Road
    Holmewood
    S42 5SH Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    98 Heath Road
    Holmewood
    S42 5SH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishEngineer10431110001
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    BritishAccountant10085240001
    PASS, Trevor
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    Amministratore
    5-7 Bridgegate
    Retford
    DN22 6AF Notts
    United KingdomBritishEngineer10085260006
    VALENTINE, Keith
    8 Kestrel Avenue
    Thorpe Hesley
    S61 2TT Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    8 Kestrel Avenue
    Thorpe Hesley
    S61 2TT Rotherham
    South Yorkshire
    BritishEngineer10431120001

    DECTON INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 04 feb 1998
    Consegnato il 11 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F.h broombank park site and field equipment at broombank park sheepbridge chesterfield derbyshire part t/n DY163115. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 feb 1998
    Consegnato il 10 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings at broombank park known as hydraulic shop sheepbridge chesterfield derbyshire title number DY215498. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 1993
    Consegnato il 30 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at broombank park road, sheepbridge, chesterfield t/no: dy 207905.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 ago 1991
    Consegnato il 30 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and broomco (489) limited under the terms of the three agreements dated 16/8/91 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property at broombank road, sheepbridge chesterfield together with all buildings & fixtures (excluding tenants fixtures).
    Persone aventi diritto
    • Broomco (479) Limited
    Transazioni
    • 30 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 ago 1991
    Consegnato il 30 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and broomco (489) limited under the terms of the three agreements dated 16/8/91 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property at broombank road, sheepbridge chesterfield together with all buildings & fixtures (excluding tenants fixtures).
    Persone aventi diritto
    • Broomco (479) Limited
    Transazioni
    • 30 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1990
    Consegnato il 28 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at sheepbridge works broombank road, chesterfield derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 mar 1989
    Consegnato il 21 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1989
    Consegnato il 21 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises k/a part of sheepbridge works, broombank road sheepbridge, chesterfield, derbyshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0