ASPRO TRAVEL LIMITED

ASPRO TRAVEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASPRO TRAVEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01447937
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASPRO TRAVEL LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ASPRO TRAVEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Cambs
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASPRO TRAVEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per ASPRO TRAVEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 apr 2010

    Stato del capitale al 06 apr 2010

    • Capitale: GBP 1,050,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Authority to strike off company 17/12/2009
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Michael William Hallisey il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Shirley Bradley il 27 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2006

    8 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2005

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ASPRO TRAVEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, Shirley
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Segretario
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    British65475670001
    HALLISEY, David Michael William
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritish1919030001
    THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    63592630006
    ASPROU, Dimitrios Michael Konstantine
    22 Dulverton Drive
    CF64 5EW Sully
    South Glamorgan
    Segretario
    22 Dulverton Drive
    CF64 5EW Sully
    South Glamorgan
    British34776150001
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Segretario
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    DETKO, Tadeusz Stephen
    Yew Tree Barn
    White Horse Lane Barton
    PR3 5AH Preston
    Lancashire
    Segretario
    Yew Tree Barn
    White Horse Lane Barton
    PR3 5AH Preston
    Lancashire
    British77446300001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    Segretario
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    British49723980004
    ASPROU, Christopher
    8 Oyster Bend
    CF64 3LW Sully
    South Glamorgan
    Amministratore
    8 Oyster Bend
    CF64 3LW Sully
    South Glamorgan
    British34457970001
    ASPROU, Dimitrios Michael Konstantine
    22 Dulverton Drive
    CF64 5EW Sully
    South Glamorgan
    Amministratore
    22 Dulverton Drive
    CF64 5EW Sully
    South Glamorgan
    British34776150001
    ASPROU, George Michael
    Longmead The Twyncyn
    CF64 4TH Dinas Powys
    South Glamorgan
    Amministratore
    Longmead The Twyncyn
    CF64 4TH Dinas Powys
    South Glamorgan
    British39020540001
    ASPROU, Georgina, Director Of Sales
    Longmead
    The Twyncyn
    CF6 Dinas Powys
    South Glamorgan
    Amministratore
    Longmead
    The Twyncyn
    CF6 Dinas Powys
    South Glamorgan
    British8324650001
    ASPROU, Michael George
    17 Caynham Avenue
    CF64 5RR Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    17 Caynham Avenue
    CF64 5RR Penarth
    South Glamorgan
    British21903720001
    CARRICK, Richard John
    10 Lovelstave
    NR1 1LW Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    10 Lovelstave
    NR1 1LW Norwich
    Norfolk
    British94107110001
    COE, Albert Henry
    48 Broad Walk
    SK9 5PL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    48 Broad Walk
    SK9 5PL Wilmslow
    Cheshire
    British3977310001
    COLLINSON, Harold Hugh
    Raaes Wyke
    Longlands Road
    LA23 1DL Windermere
    Cumbria
    Amministratore
    Raaes Wyke
    Longlands Road
    LA23 1DL Windermere
    Cumbria
    EnglandBritish104953440001
    CROSSLAND, David
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Amministratore
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    JerseyBritish3977330005
    JANSEN, Philip Eric Rene
    The Orchard
    Chiswick
    W4 1JX London
    12
    Amministratore
    The Orchard
    Chiswick
    W4 1JX London
    12
    United KingdomBritish152801620001
    JARDINE, David
    The Old Cottage
    Hough End
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Cottage
    Hough End
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    British105046880001
    KANTOR, Kazimiera Teresa
    27 Springhill Road
    OX5 1RX Begbroke
    Oxfordshire
    Amministratore
    27 Springhill Road
    OX5 1RX Begbroke
    Oxfordshire
    United KingdomBritish98839680001
    MARCALL, Raymond George
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish3977340001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritish49723980004
    MOTTERSHEAD, Christopher Alan Leigh
    The Fairways 12 Prestwick Close
    Tytherington
    SK10 2TH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    The Fairways 12 Prestwick Close
    Tytherington
    SK10 2TH Macclesfield
    Cheshire
    British77719420004
    WASLANDER, Ton
    14 College Close
    SK9 5PY Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    14 College Close
    SK9 5PY Wilmslow
    Cheshire
    British5917120001
    WILSON, Duncan Campbell
    120 Terregles Avenue
    Maxwell Park Pollokshields
    G41 4LJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    120 Terregles Avenue
    Maxwell Park Pollokshields
    G41 4LJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish111941210001

    ASPRO TRAVEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 28 gen 1987
    Consegnato il 04 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42 & 42A, bute street, cardiff, south glamorgan title no:- wa 172019.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 30 gen 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3, bute place, cardiff, south glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 30 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or inter european airways limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1985
    Consegnato il 22 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Shop premises. K/a 80 bull street birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 mag 1984
    Consegnato il 30 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 42 & 42A bute street cardiff south glamorgan title no wa 172019.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 13 ott 1983
    Consegnato il 20 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M20). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1982
    Consegnato il 14 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H:- 42 bute street cardiff, south glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0