CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED

CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01448409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp, 30
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCORE OUTDOOR (MIDLANDS) LIMITED06 set 199906 set 1999
    VISION POSTERS LIMITED13 set 197913 set 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2022

    11 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD a C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 11 mag 2022

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 33 Golden Square London W1F 9JT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 33 Golden Square London W1F 9JT a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD in data 05 ott 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2021

    LRESSP

    Notifica di Clear Channel Overseas Limited come persona con controllo significativo il 03 mar 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di Clear Channel Uk Limited come persona con controllo significativo il 03 mar 2021

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 dic 2020

    • Capitale: GBP 1.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account of the company of £20,000 be cancelled in it's entirety. 15/12/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Byron Kee Chye Hoo come amministratore in data 04 mag 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Adam Paul Raymond Tow come amministratore in data 04 mag 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Clear Channel Uk Limited come persona con controllo significativo il 12 feb 2018

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COCHRANE, Justin Malcolm Brian
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandEnglish110390650002
    TOW, Adam Paul Raymond
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandBritish66766420004
    ANDREWS, Nick
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Segretario
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    British109746840001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    Segretario
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    British11996520001
    EMBREY, Jacqueline Gaylor
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British46477960001
    EMENY, Selina Holliday
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    Segretario
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    British76404320002
    TERRY, Philip
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    British76924060001
    ANDREWS, Nicholas James
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Amministratore
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish168572900001
    ATKINSON, Robert Nigel
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Amministratore
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish128922360001
    BEVAN, Jonathan David
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    Amministratore
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    United KingdomBritish110358490001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    EnglandBritish11996520001
    BOWMAN, John Reid
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    Amministratore
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritish79292840001
    FINDLAY, Richard
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish35695630001
    FRANCE, Julie
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    Amministratore
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    EnglandBritish110526070001
    GEORGE, Stephen Terence
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British24649850001
    HOO, Byron Kee Chye
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Amministratore
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    EnglandBritish214640470001
    O'HARA, Henry John
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    British11996550003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Amministratore
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish67052550001
    SPRING, Stephanie
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    Amministratore
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    EnglandBritish102849950001
    WILSON, Alan Raeburn
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    Amministratore
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    British33799400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Clear Channel Overseas Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    03 mar 2021
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Uk
    Numero di registrazione01441672
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Clear Channel Uk Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    12 feb 2018
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione950526
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Clear Channel Central Limited
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    31 gen 2017
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish Law
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazioneSc198208
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 61 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM394463 and proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 60 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM379419 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 3/4/5 water court,36 water street,birmingham west midlands t/n WM473698 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 dic 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 lug 1993
    Consegnato il 16 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 1992
    Consegnato il 11 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1991
    Consegnato il 13 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    61 charlotte street birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • T S B Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1991
    Consegnato il 13 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 3, 4 and 5 lansdowne house, (otherwise known as water court) water street, birmingham, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • T S B Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1991
    Consegnato il 13 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    60 charlotte street birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • T S B Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 lug 1990
    Consegnato il 11 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • T S B Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 mar 1990
    Consegnato il 08 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property 60 and 61 charlotte street, birmingham west midlands t/ns wm 379419 and wm 394463 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 01 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H units 3, 4 & 5 lansdowne house, water street birmingham W. midlands & goods & goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1986
    Consegnato il 25 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H three stoney office premises known as 61 charlotte street, birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Norwich General Trust Limited
    Transazioni
    • 25 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1986
    Consegnato il 06 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property being part of 57/61 charlotte street, birmingham.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 06 giu 1985
    Consegnato il 12 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2021Inizio della liquidazione
    12 mar 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0