PRIMETIME NO. 2 LIMITED

PRIMETIME NO. 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRIMETIME NO. 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01448776
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    • Attività di distribuzione di programmi televisivi (59133) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Shepherds Building Central
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OXFORD SCIENTIFIC FILMS LIMITED29 nov 200429 nov 2004
    SOUTHERN TELEVISION LIMITED26 feb 198226 feb 1982
    SOUTHERN PICTURES LIMITED14 set 197914 set 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 01 set 2022

    • Capitale: GBP 0.10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Cessazione della carica di Marie Lucile Schweitzer come amministratore in data 05 ago 2022

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Shepherds Building Central Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way London W14 0EE United Kingdom a Shepherds Building Central Charecroft Way London W14 0EE in data 03 ago 2022

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Nomina di Ms Marie Schweitzer come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Anthony John Richards come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Catherine Patricia Payne come amministratore in data 03 ago 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Wim Theo Gaby Ponnet come amministratore in data 03 ago 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Terry William Downing come amministratore in data 03 ago 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Terry William Downing come amministratore in data 09 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony John Richards come amministratore in data 09 gen 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Catherine Patricia Payne come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wim Theo Gaby Ponnet come amministratore in data 20 nov 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KEPPLER, Bronagh Elizabeth Ann
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Segretario
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    172334810001
    PAYNE, Catherine Patricia
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandAustralian205324840001
    RICHARDS, Anthony John
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandBritish269661310001
    BARRON, Maureen Patricia
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    Segretario
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    Australian71849590001
    IRLAM, Felicity Mary
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    Segretario
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    British42627330001
    MEACOCK, Catherine Anne
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    Segretario
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    British46175710002
    TATE, Maxine
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    Segretario
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    British60430270003
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    Segretario
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    38636470004
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    Euston Square
    NW1 2BW London
    Segretario nominato
    22 Melton Street
    Euston Square
    NW1 2BW London
    900007560001
    BALNAVES, Neil Richard
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Amministratore
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Australian53758580001
    BIRKS, Clare
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    Amministratore
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    United KingdomBritish60648500001
    CLARK, Peter Antony
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    Amministratore
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    United KingdomBritish60713200001
    DOWNING, Terry William
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritish109287950001
    IRVINE, Ian Alexander Noble
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    Amministratore
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    British53758680001
    LEWORTHY, Judy
    43 Hammersmith Grove
    W6 0NE London
    Amministratore
    43 Hammersmith Grove
    W6 0NE London
    British66895130001
    LEWORTHY, Richard
    43 Hammersmith Grove
    W6 ONE London
    Amministratore
    43 Hammersmith Grove
    W6 ONE London
    British95593600001
    LYONS, Frank
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    Amministratore
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    Irish71588050002
    PAYNE, Catherine Patricia
    Peninsula Heights
    93 Albert Embankment
    SE1 7TY London
    34
    United Kingdom
    Amministratore
    Peninsula Heights
    93 Albert Embankment
    SE1 7TY London
    34
    United Kingdom
    United KingdomAustralian69630880003
    PONNET, Wim Theo Gaby
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceBelgian210379090001
    PRICE, Richard Shirvell
    Beech Knoll House
    Aldbourne
    SN8 2EJ Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Beech Knoll House
    Aldbourne
    SN8 2EJ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish13640490003
    RICHARDS, Anthony John
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritish138456730002
    SAY, David Giles Ashworth
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Amministratore
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian53758640001
    SAY, David Giles Ashworth
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Amministratore
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian53758640001
    SCHWEITZER, Marie Lucile
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Amministratore
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceFrench272749510001
    WILSON, Nigel Peter
    158 Broomwood Road
    SW11 6JY London
    Amministratore
    158 Broomwood Road
    SW11 6JY London
    British77540330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Primetime Limited
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    England
    30 giu 2016
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 1948 To 1981
    Luogo di registrazioneCompanies Register England And Wales
    Numero di registrazione901456
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PRIMETIME NO. 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 nov 2000
    Consegnato il 17 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land the real property tangible movable property all the tangible movable property accounts with the bank all rights and claims to which the company at the date of creation of the charge or may thereafter become entitled in relation to all moneys at the date of creation of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any bank accounts opened or maintained with the bank together with all rights relating or attaching thereto (including the right to interest) intellectual property the intellectual property goodwill all goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westpac Banking Corporation
    Transazioni
    • 17 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ago 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 mag 1994
    Consegnato il 03 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 03 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 25 mag 1994
    Consegnato il 27 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreements and/or any other agreement (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 09 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 28 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "principal agreement" dated 14TH february 1994 and this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 lug 1989
    Consegnato il 12 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0