PRIMETIME NO. 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRIMETIME NO. 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01448776 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
- Attività di distribuzione di programmi televisivi (59133) / Informazione e comunicazione
Dove si trova PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Shepherds Building Central Charecroft Way W14 0EE London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OXFORD SCIENTIFIC FILMS LIMITED | 29 nov 2004 | 29 nov 2004 |
| SOUTHERN TELEVISION LIMITED | 26 feb 1982 | 26 feb 1982 |
| SOUTHERN PICTURES LIMITED | 14 set 1979 | 14 set 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 01 set 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Marie Lucile Schweitzer come amministratore in data 05 ago 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Shepherds Building Central Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way London W14 0EE United Kingdom a Shepherds Building Central Charecroft Way London W14 0EE in data 03 ago 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Ms Marie Schweitzer come amministratore in data 03 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Anthony John Richards come amministratore in data 03 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Catherine Patricia Payne come amministratore in data 03 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Wim Theo Gaby Ponnet come amministratore in data 03 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Terry William Downing come amministratore in data 03 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Terry William Downing come amministratore in data 09 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony John Richards come amministratore in data 09 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Patricia Payne come amministratore in data 25 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Wim Theo Gaby Ponnet come amministratore in data 20 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPPLER, Bronagh Elizabeth Ann | Segretario | Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | 172334810001 | |||||||
| PAYNE, Catherine Patricia | Amministratore | Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | England | Australian | 205324840001 | |||||
| RICHARDS, Anthony John | Amministratore | Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | England | British | 269661310001 | |||||
| BARRON, Maureen Patricia | Segretario | 277 Edgecliff Road Woollahra FOREIGN Sydney New South Wales 2025 Australia | Australian | 71849590001 | ||||||
| IRLAM, Felicity Mary | Segretario | 2 Suffolk Villas Longfield Street SW18 5RG London | British | 42627330001 | ||||||
| MEACOCK, Catherine Anne | Segretario | 6b Somerset Road Ealing W13 9PB London | British | 46175710002 | ||||||
| TATE, Maxine | Segretario | 35a Walterton Road W9 3PE London | British | 60430270003 | ||||||
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | 38636470004 | |||||||
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 22 Melton Street Euston Square NW1 2BW London | 900007560001 | |||||||
| BALNAVES, Neil Richard | Amministratore | 1 Milton Avenue Mosman New South Wales 2088 Australia | Australian | 53758580001 | ||||||
| BIRKS, Clare | Amministratore | 15 Saint Michaels Road SW9 0SN London | United Kingdom | British | 60648500001 | |||||
| CLARK, Peter Antony | Amministratore | 108 Roseneath Road SW11 6AQ London | United Kingdom | British | 60713200001 | |||||
| DOWNING, Terry William | Amministratore | Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | United Kingdom | British | 109287950001 | |||||
| IRVINE, Ian Alexander Noble | Amministratore | 14 Tregunter Road SW10 9LR London | British | 53758680001 | ||||||
| LEWORTHY, Judy | Amministratore | 43 Hammersmith Grove W6 0NE London | British | 66895130001 | ||||||
| LEWORTHY, Richard | Amministratore | 43 Hammersmith Grove W6 ONE London | British | 95593600001 | ||||||
| LYONS, Frank | Amministratore | 48 Dymock Street SW6 3HA London | Irish | 71588050002 | ||||||
| PAYNE, Catherine Patricia | Amministratore | Peninsula Heights 93 Albert Embankment SE1 7TY London 34 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 69630880003 | |||||
| PONNET, Wim Theo Gaby | Amministratore | Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | France | Belgian | 210379090001 | |||||
| PRICE, Richard Shirvell | Amministratore | Beech Knoll House Aldbourne SN8 2EJ Marlborough Wiltshire | England | British | 13640490003 | |||||
| RICHARDS, Anthony John | Amministratore | Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | United Kingdom | British | 138456730002 | |||||
| SAY, David Giles Ashworth | Amministratore | 33 Lynbara Avenue St Ives New South Wales 2075 Australia | Australian | 53758640001 | ||||||
| SAY, David Giles Ashworth | Amministratore | 33 Lynbara Avenue St Ives New South Wales 2075 Australia | Australian | 53758640001 | ||||||
| SCHWEITZER, Marie Lucile | Amministratore | Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central United Kingdom | France | French | 272749510001 | |||||
| WILSON, Nigel Peter | Amministratore | 158 Broomwood Road SW11 6JY London | British | 77540330001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMETIME NO. 2 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primetime Limited | 30 giu 2016 | Charecroft Way W14 0EE London Shepherds Building Central England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PRIMETIME NO. 2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 08 nov 2000 Consegnato il 17 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land the real property tangible movable property all the tangible movable property accounts with the bank all rights and claims to which the company at the date of creation of the charge or may thereafter become entitled in relation to all moneys at the date of creation of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any bank accounts opened or maintained with the bank together with all rights relating or attaching thereto (including the right to interest) intellectual property the intellectual property goodwill all goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 ago 1999 Consegnato il 12 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 25 mag 1994 Consegnato il 03 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 25 mag 1994 Consegnato il 27 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreements and/or any other agreement (as defined in the deed) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Creato il 14 feb 1994 Consegnato il 28 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "principal agreement" dated 14TH february 1994 and this deed | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 lug 1989 Consegnato il 12 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0