DBS MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
Nome della società | DBS MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01451043 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DBS MANAGEMENT LIMITED?
- Attività di società holding di servizi finanziari (64205) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova DBS MANAGEMENT LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DBS MANAGEMENT LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
DBS MANAGEMENT PLC | 02 ago 1995 | 02 ago 1995 |
DBS MANAGEMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | 27 set 1979 | 27 set 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DBS MANAGEMENT LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per DBS MANAGEMENT LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 05 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Cowan come amministratore in data 12 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 12 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Notifica di London and Manchester Group Limited come persona con controllo significativo il 10 apr 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Sesame Bankhall Group Limited come persona con controllo significativo il 10 apr 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Burlison come amministratore in data 27 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Aviva Company Secretarial Services Limited come segretario in data 17 mar 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Friends Life Secretarial Services Limited come segretario in data 17 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 15 feb 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DBS MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
ROSE, David Rowley | Amministratore | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 89567200001 | ||||||||
CARTWRIGHT, Ceilo Bicol | Segretario | 3 Becketts Park Road Headingley LS6 3PG Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 74876530001 | |||||||||
CHAPMAN, Clive Richard | Segretario | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | British | Director | 86129050001 | |||||||||
ELLIS, Robert Gordon | Segretario | Severals Oakwood PO18 9AL Chichester West Sussex | British | Solicitor | 33165610001 | |||||||||
GRAY, Elizabeth Andrea | Segretario | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
GREENWOOD, Martin James | Segretario | Stonecroft Daisy Lea Lane HD3 3LL Huddersfield West Yorkshire | British | 66171900001 | ||||||||||
HAM, Richard Laurence | Segretario | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
MONGER, Diana | Segretario | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | 148089070001 | |||||||||||
STEWART, David | Segretario | Beverley House 23 Norwood Park HD2 2DU Huddersfield West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 38667100004 | |||||||||
WATERS, Paul Christopher | Segretario | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom |
| 169080040001 | ||||||||||
ANDREW, Kenneth, Doctor | Amministratore | 16 Portsea Place W2 2BL London | British | Company Director | 78357920003 | |||||||||
BATTERHAM, Christopher Michael | Amministratore | Vale Farm House Hawridge Vale HP5 2UG Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 48567920002 | ||||||||
BUDGE, Kevin John | Amministratore | The Old Nursery The Dash Kings Lane Longcot SN7 7SS Faringdon Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 97406200001 | |||||||||
BURLISON, David John | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 202289710001 | ||||||||
CHAPMAN, Clive Richard | Amministratore | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Finance Director | 86129050001 | ||||||||
CORDLE, Paul Howard | Amministratore | 2 Quemerford Farm Cottages SN11 8UA Calne Wiltshire | British | Director | 19082070002 | |||||||||
COUZENS, Michael Alastair | Amministratore | Dorking RH4 1QA Surrey Pixham End England | United Kingdom | British | Company Director | 75553130006 | ||||||||
COWAN, John | Amministratore | Montagu Square Westminster W1H 2LW London 47 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 109138540001 | ||||||||
DAVY, Kenneth Ernest | Amministratore | Holly Mount 3 Paget Crescent Birkby HD2 2BZ Huddersfield West Yorkshire | England | British | Investment Consultant | 6078230001 | ||||||||
DRURY, Peter Stanley | Amministratore | 30 Timbercliffe Summit OL15 9QL Littleborough Lancs | British | Investment Consultant | 33205780001 | |||||||||
GALE, Patrick Nigel Christopher | Amministratore | Mallams 62 High Street OX14 4EJ Milton Oxfordshire | England | British | Chief Executive Officer | 149359970001 | ||||||||
GREENWOOD, Martin James | Amministratore | Stonecroft Daisy Lea Lane HD3 3LL Huddersfield West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 66171900001 | ||||||||
HIDDLESTON, David James | Amministratore | 4 Grovewood Close WD3 5PU Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | General Manager Financial Services | 74642230001 | ||||||||
HIGGINSON, George | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | Northern Ireland | British | Chief Operating Officer | 74690950003 | ||||||||
HOOPER, Paul | Amministratore | Dorking RH4 1QA Surrey Pixham End England England | United Kingdom | British | Company Director | 152500600001 | ||||||||
JILLINGS, Godfrey Frank | Amministratore | 47 Hurlingham Square Peterborough Road SW6 3DZ London | United Kingdom | British | Consultant | 54331060001 | ||||||||
KEMPSTER, William Anthony | Amministratore | Tulligee Ranelagh Drive RG12 9DA Bracknell Berkshire | England | British | Company Director | 50190310001 | ||||||||
MANSELL, Edgar John | Amministratore | 1 Levens Close Killinghall HG3 2BN Harrogate North Yorkshire | British | Investment Consultant | 63598410001 | |||||||||
MARTIN, Ivan | Amministratore | Dorking RH4 1QA Surrey Pixham End England England | England | British | Executive Chairman | 123233030001 | ||||||||
MARTIN, Ivan | Amministratore | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | Director | 123233030001 | ||||||||
NEWMAN, James Allen | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 184671850003 | ||||||||
STEWART, David | Amministratore | Beverley House 23 Norwood Park HD2 2DU Huddersfield West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 38667100004 | |||||||||
TAYLOR, Christopher | Amministratore | Yorton House Yorton SY4 3EU Shrewsbury Shropshire | England | British | Company Director | 94869820001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DBS MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London And Manchester Group Limited | 10 apr 2018 | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Sesame Bankhall Group Limited | 06 apr 2016 | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DBS MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Creato il 19 dic 2006 Consegnato il 29 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Creato il 17 set 2003 Consegnato il 01 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling 95. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Share charge | Creato il 21 giu 2001 Consegnato il 04 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari As a continuing security for the payment to the bank of the indebtedness the company hereby charges with full title guarantee in favour of the bank by way of first fixed charge all the securities (as defined) belonging to the company or in which the company has as interest together with distribution rights (as defined). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 giu 2001 Consegnato il 04 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 16 apr 1996 Consegnato il 17 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land situate at and k/a independence house holly bank road huddersfied west yorkshire WYK477019 and the proceeds of sale thereof goodwill of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 16 apr 1996 Consegnato il 17 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land adjacent to independence house holly bank road huddersfiel west yorkshire WYK506481 and the proceeds of sale thereon all goodwill of the company at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 set 1992 Consegnato il 25 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First by way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above reffered to land adjacent to independence house,holly bank road,lindley,huddersfield,west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 set 1992 Consegnato il 25 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings(other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above referred to acre house,64 acxre street,lindley,huddersfield west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 ago 1990 Consegnato il 24 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the south side of hollybank road lindley huddersfield west yorkshire (see 395 ref M65 and contd sheets for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge. | Creato il 07 ago 1990 Consegnato il 24 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
DBS MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0