DBS MANAGEMENT LIMITED

DBS MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDBS MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01451043
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DBS MANAGEMENT LIMITED?

    • Attività di società holding di servizi finanziari (64205) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DBS MANAGEMENT PLC02 ago 199502 ago 1995
    DBS MANAGEMENT PUBLIC LIMITED COMPANY27 set 197927 set 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 05 ott 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 set 2018

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di John Cowan come amministratore in data 12 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 12 set 2018

    2 pagineAP01

    Notifica di London and Manchester Group Limited come persona con controllo significativo il 10 apr 2018

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione di Sesame Bankhall Group Limited come persona con controllo significativo il 10 apr 2018

    1 paginePSC07

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di David John Burlison come amministratore in data 27 lug 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Aviva Company Secretarial Services Limited come segretario in data 17 mar 2017

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Friends Life Secretarial Services Limited come segretario in data 17 mar 2017

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 feb 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2016

    Stato del capitale al 12 mag 2016

    • Capitale: GBP 495,416.45
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2084205
    1278390004
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector89567200001
    CARTWRIGHT, Ceilo Bicol
    3 Becketts Park Road
    Headingley
    LS6 3PG Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Becketts Park Road
    Headingley
    LS6 3PG Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant74876530001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Segretario
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    BritishDirector86129050001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Segretario
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    BritishSolicitor33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    GREENWOOD, Martin James
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    British66171900001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Segretario
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    148089070001
    STEWART, David
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant38667100004
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7350629
    169080040001
    ANDREW, Kenneth, Doctor
    16 Portsea Place
    W2 2BL London
    Amministratore
    16 Portsea Place
    W2 2BL London
    BritishCompany Director78357920003
    BATTERHAM, Christopher Michael
    Vale Farm House
    Hawridge Vale
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Vale Farm House
    Hawridge Vale
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director48567920002
    BUDGE, Kevin John
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant97406200001
    BURLISON, David John
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202289710001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Amministratore
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishFinance Director86129050001
    CORDLE, Paul Howard
    2 Quemerford Farm Cottages
    SN11 8UA Calne
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Quemerford Farm Cottages
    SN11 8UA Calne
    Wiltshire
    BritishDirector19082070002
    COUZENS, Michael Alastair
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    Amministratore
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    United KingdomBritishCompany Director75553130006
    COWAN, John
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    Amministratore
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director109138540001
    DAVY, Kenneth Ernest
    Holly Mount 3 Paget Crescent
    Birkby
    HD2 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Holly Mount 3 Paget Crescent
    Birkby
    HD2 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishInvestment Consultant6078230001
    DRURY, Peter Stanley
    30 Timbercliffe
    Summit
    OL15 9QL Littleborough
    Lancs
    Amministratore
    30 Timbercliffe
    Summit
    OL15 9QL Littleborough
    Lancs
    BritishInvestment Consultant33205780001
    GALE, Patrick Nigel Christopher
    Mallams
    62 High Street
    OX14 4EJ Milton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mallams
    62 High Street
    OX14 4EJ Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritishChief Executive Officer149359970001
    GREENWOOD, Martin James
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stonecroft
    Daisy Lea Lane
    HD3 3LL Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant66171900001
    HIDDLESTON, David James
    4 Grovewood Close
    WD3 5PU Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Grovewood Close
    WD3 5PU Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Manager Financial Services74642230001
    HIGGINSON, George
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Northern IrelandBritishChief Operating Officer74690950003
    HOOPER, Paul
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Amministratore
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director152500600001
    JILLINGS, Godfrey Frank
    47 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    Amministratore
    47 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    United KingdomBritishConsultant54331060001
    KEMPSTER, William Anthony
    Tulligee Ranelagh Drive
    RG12 9DA Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Tulligee Ranelagh Drive
    RG12 9DA Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director50190310001
    MANSELL, Edgar John
    1 Levens Close
    Killinghall
    HG3 2BN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Levens Close
    Killinghall
    HG3 2BN Harrogate
    North Yorkshire
    BritishInvestment Consultant63598410001
    MARTIN, Ivan
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Amministratore
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    EnglandBritishExecutive Chairman123233030001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Amministratore
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritishDirector123233030001
    NEWMAN, James Allen
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Director184671850003
    STEWART, David
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Beverley House
    23 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant38667100004
    TAYLOR, Christopher
    Yorton House
    Yorton
    SY4 3EU Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Yorton House
    Yorton
    SY4 3EU Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director94869820001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DBS MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    10 apr 2018
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1594941
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3573352
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DBS MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling 95.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 21 giu 2001
    Consegnato il 04 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As a continuing security for the payment to the bank of the indebtedness the company hereby charges with full title guarantee in favour of the bank by way of first fixed charge all the securities (as defined) belonging to the company or in which the company has as interest together with distribution rights (as defined).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2001
    Consegnato il 04 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 apr 1996
    Consegnato il 17 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate at and k/a independence house holly bank road huddersfied west yorkshire WYK477019 and the proceeds of sale thereof goodwill of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 apr 1996
    Consegnato il 17 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land adjacent to independence house holly bank road huddersfiel west yorkshire WYK506481 and the proceeds of sale thereon all goodwill of the company at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 apr 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First by way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above reffered to land adjacent to independence house,holly bank road,lindley,huddersfield,west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all the property described in the schedule hereto including all fixtures and fittings(other than trade fixtures and fittings) plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the same the schedule above referred to acre house,64 acxre street,lindley,huddersfield west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1990
    Consegnato il 24 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of hollybank road lindley huddersfield west yorkshire (see 395 ref M65 and contd sheets for full details).
    Persone aventi diritto
    • Skandia Financial Services Limited.
    Transazioni
    • 24 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge.
    Creato il 07 ago 1990
    Consegnato il 24 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Skandia Financial Services Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DBS MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 set 2018Inizio della liquidazione
    23 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0