SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)
Panoramica
Nome della società | SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE) |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01451175 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Noleggio di proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere protette da diritto d'autore (77400) / Attività amministrative e di supporto
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
- Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione
Dove si trova SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Indirizzo della sede legale | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CAREGUARD LIMITED | 28 set 1979 | 28 set 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 24 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 07 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 24 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 mar 2024 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2022 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021 | 12 pagine | AA | ||
Nomina di Debbie Olutunu Giwa come amministratore in data 28 lug 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di John Charles Roger Tennent come amministratore in data 27 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Philip Charles John William Cliff come amministratore in data 02 mag 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Graeme Melville Danton come segretario in data 16 apr 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Amanda Louise Perrin come amministratore in data 16 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christopher John Ward Sparrow come segretario in data 16 apr 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Christopher John Ward Sparrow come segretario in data 01 gen 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Benedict John Anstey come segretario in data 01 gen 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 11 pagine | AA | ||
Nomina di Ms Amanda Louise Perrin come amministratore in data 12 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Rosemary Howell come amministratore in data 23 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr John Charles Roger Tennent come amministratore in data 28 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Michael Anthony Rogerson come amministratore in data 28 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANTON, Graeme Melville | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 257947230001 | |||||||||||
CLIFF, Philip Charles John William | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | England | British | Operations Director | 71888190002 | ||||||||
GIWA, Debbie Olutunu | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | England | British | Accountant | 195374970001 | ||||||||
ANSTEY, Benedict John | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 213210070002 | |||||||||||
ARMSON, Frederick Simon Arden | Segretario | Broad Oak Hurley SL6 5LW Maidenhead Berkshire | British | 30944520001 | ||||||||||
COLLINS, Robin Peter | Segretario | St Catherine's Wood GU15 2NF Camberely 13 Surrey | British | Director Of Finance | 108200120002 | |||||||||
COLLINS, Robin Peter | Segretario | 11 Redwood Drive SL5 0LW Ascot Berkshire | British | Director Of Finance | 108200120001 | |||||||||
DOMINGUES, Rui Manuel | Segretario | 74 Hunters Road KT9 1RT Chessington Surrey | Portuguese | 126150160001 | ||||||||||
EDEN, Graham Anthony | Segretario | Begbie Road Blackheath SE3 8DA London 47 | British | 42330540001 | ||||||||||
KING, Peter David | Segretario | 64 Nightingale Crescent West Horsley KT24 6PD Leatherhead Surrey | British | Chief Executive Officer | 123039680001 | |||||||||
KIRBY, David John | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 203106730001 | |||||||||||
MACAULAY, Partricia | Segretario | 3 Carrow Road KT12 3JZ Walton On Thames Surrey | British | Director Of Finance | 78762120001 | |||||||||
NOTMAN, Stephen Robert | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 199810860001 | |||||||||||
SCREGG, Susan Elizabeth | Segretario | Knapp House Sparrowhawk Close Ewshot GU10 5TJ Farnham Surrey | British | 59675860001 | ||||||||||
SPARROW, Christopher John Ward | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 253839080001 | |||||||||||
WILSON, Kathryn | Segretario | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | 170963240001 | |||||||||||
ANTHONY KENNETH FARNFIELD | Segretario | Ray Park Avenue SL6 8DX Maidenhead 48 Berkshire United Kingdom |
| 158765980002 | ||||||||||
ARMSON, Frederick Simon Arden | Amministratore | Broad Oak Hurley SL6 5LW Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Charity Chief Executive | 30944520001 | ||||||||
AUTON, Heather May | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | United Kingdom | British | Marketing Consultant | 110987630001 | ||||||||
CHARMAN, Michael | Amministratore | 10 New Street LE1 5ND Leicester | British | Solicitor | 2328490001 | |||||||||
CLARKSON WEBB, Michael Robert | Amministratore | Mill Mere Staceys Farm Road Elstead GU8 6EN Godalming Surrey | British | Chartered Accountant | 16445630001 | |||||||||
CONNOLLY, Brendan Stephen | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | United Kingdom | British | Interim Finance Director | 56031910002 | ||||||||
CORRIGAN, Kevin Francis | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | United Kingdom | British | Investment Manager | 141827670001 | ||||||||
DAVIES, Bryn John | Amministratore | 52 Llewelyn Street Trecynol CF44 8HU Aberdare The Bungalow Mid Glamorgan United Kingdom | Wales | British | Garage Owner | 114592550001 | ||||||||
GIBSON, David Horsburgh | Amministratore | Paprills Farm CM3 8BW East Hanningfield Essex | British | Chartered Accountant | 6775950001 | |||||||||
HOWELL, Rosemary | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | Wales | British | Interim Manager | 173258820001 | ||||||||
KERRY, David Paul | Amministratore | 42 Hebden Avenue CA2 6TT Carlisle Cumbria | Vic British | Industrial Manager | 65447590002 | |||||||||
KING, Peter David | Amministratore | 64 Nightingale Crescent West Horsley KT24 6PD Leatherhead Surrey | England | British | Chief Executive Officer | 123039680001 | ||||||||
KIRBY-RIDER, Rachel Louise | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | United Kingdom | British | Director | 137244010001 | ||||||||
KRAUSE, Sherine | Amministratore | The Upper Mill Kingston Road KT17 2AF Ewell Surrey | England | British | Fundraiser | 110765250001 | ||||||||
LEE, Anthony Mervyn | Amministratore | The Post House The Street GU4 7ST West Clandon Surrey | England | British | Director | 56655880002 | ||||||||
MANN, Jean Helen Leah | Amministratore | Bay Trees Burnhams Road Little Bookham KT23 3AU Leatherhead Surrey | British | Retired | 54040190001 | |||||||||
MCCARTNEY, Jennifer Margaret | Amministratore | 90 Tamworth Drive GU51 2UP Fleet Hampshire | England | British | Account Manager | 21517640002 | ||||||||
MINIHANE, Daphne | Amministratore | Les Croix Rue Db Tas De Geon Jersey Channel Islands | British | Retired | 30944530001 | |||||||||
PAYNE, Jeremy | Amministratore | 22 Eastern Road SO41 9HG Lymington Hampshire | British | Fundraiser/Marketing | 108689490001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SAMARITAN ENTERPRISES LIMITED(THE)?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samaritans | 06 apr 2016 | Kingston Road KT17 2AF Epsom The Upper Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0