PRIME MOTOR FACTORS LTD.
Panoramica
Nome della società | PRIME MOTOR FACTORS LTD. |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01453002 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
- Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli (45310) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Indirizzo della sede legale | C/O Clough Corporate Solutions Limited Vicarage Chambers 9 Park Square East LS1 2LH Leeds West Yorkshire England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SPEEDY MOTOR FACTORS LIMITED | 11 apr 1986 | 11 apr 1986 |
SWIFT MOTOR SERVICES (TREDEN) LIMITED | 09 ott 1979 | 09 ott 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Matrix House Basing View Basingstoke RG21 4DZ England a C/O Clough Corporate Solutions Limited Vicarage Chambers 9 Park Square East Leeds West Yorkshire LS1 2LH in data 29 set 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Clough Corporate Solutions Limited Vicarage Chambers 9 Park Square East Leeds West Yorkshire LS1 2LH a Matrix House Basing View Basingstoke RG21 4DZ in data 22 ago 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Frederick Coombes il 22 ago 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr John Frederick Coombes il 22 ago 2022 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da New Chatford House Centurion Way Cleckheaton West Yorkshire BD19 3QB a C/O Clough Corporate Solutions Limited Vicarage Chambers 9 Park Square East Leeds West Yorkshire LS1 2LH in data 15 ago 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Matrix House Basing View Basingstoke RG21 4DZ England a New Chatford House Centurion Way Cleckheaton West Yorkshire BD19 3QB in data 04 gen 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA a Matrix House Basing View Basingstoke RG21 4DZ in data 04 mag 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jean-Jacques Mathieu Lafont come amministratore in data 19 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alistair Stuart Brown come amministratore in data 19 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jean-Jacques Mathieu Lafont il 02 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jean-Jacques Mathieu Lafont il 02 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alistair Stuart Brown il 02 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOMBES, John Frederick | Segretario | Roydsdale Way Euroway Industrial Estate BD4 6SE Bradford Roydsdale House England | British | Accountant | 74985930002 | |||||
COOMBES, John Frederick | Amministratore | Roydsdale Way Euroway Industrial Estate BD4 6SE Bradford Roydsdale House England | England | British | Finance Director | 74985930002 | ||||
DAVIE, Gary Paul | Segretario | 155 Station Road B30 1DD Kings Norton West Midlands | British | 122264860001 | ||||||
DAWKINS, Dennis | Segretario | 48 Sandringham Road NW2 5EL London | British | 22516670001 | ||||||
WILES, Sara Louise | Segretario | Oaklands The Avenue, South Nutfield RH1 5RY Redhill Surrey | British | 74486350001 | ||||||
WILES, Trevor Jeffrey | Segretario | Oaklands The Avenue South Nutfield RH1 5RY Redhill Surrey | British | 24500760002 | ||||||
BROWN, Alistair Stuart | Amministratore | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA | Switzerland | New Zealander | Director | 115184770002 | ||||
KING, Paul | Amministratore | 6 Osprey Close SM1 2XS Cheam Surrey | British | General Manager | 61232160002 | |||||
LAFONT, Jean-Jacques Mathieu | Amministratore | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA | Switzerland | Belgian | Company Director | 62978960003 | ||||
THOMAS-KEEPING, Lindsay Charles | Amministratore | Cromwell House Stanford In The Vale SN7 8NQ Faringdon Oxfordshire | British | Director | 108057370001 | |||||
WILES, Sara Louise | Amministratore | Oaklands The Avenue, South Nutfield RH1 5RY Redhill Surrey | British | Secretary | 74486350001 | |||||
WILES, Trevor Jeffrey | Amministratore | Oaklands The Avenue South Nutfield RH1 5RY Redhill Surrey | England | British | Director | 24500760002 | ||||
WILLS, Harry | Amministratore | 16 Coppice Road CV31 2JE Leamington Spa Warwickshire | British | Sales Director | 35391700001 | |||||
WINNING, Alan Raymond | Amministratore | 66 Langley Walk Langley Green RH11 7LR Crawley West Sussex | British | Director | 22516680002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRIME MOTOR FACTORS LTD.?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Automotive Uk Limited | 06 apr 2016 | Colmore Square B4 6AA Birmingham No. 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PRIME MOTOR FACTORS LTD. ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 25 feb 2015 Consegnato il 04 mar 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 05 ott 2006 Consegnato il 13 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 02 feb 2001 Consegnato il 09 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 18 apr 1994 Consegnato il 26 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific charge over all plant machinery vehicles computers and office and other equipment both present and future. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
PRIME MOTOR FACTORS LTD. ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0