RICHOUX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRICHOUX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01454511
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RICHOUX LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova RICHOUX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RICHOUX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RESTAURANTS INTERNATIONAL LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    CORANBAR LIMITED16 ott 197916 ott 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di RICHOUX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per RICHOUX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    25 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    105 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 16 dic 2021

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    36 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    38 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    8 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 School Road 2nd Floor Elizabeth House Tilehurst Reading RG31 5AL England a Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 25 gen 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    38 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 nov 2017

    • Capitale: GBP 965,264.28
    4 pagineSH01

    Nomina di Mr Anwer Sarwar Piracha come segretario in data 27 nov 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Susan Jane Ludley come segretario in data 27 nov 2017

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di RICHOUX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PIRACHA, Anwer Sarwar
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Segretario
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    240897630001
    DILIBERTO, Salvatore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandItalian124279580001
    KAYE, Jonathan Samuel
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    United Kingdom
    Amministratore
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    United Kingdom
    EnglandBritish80553720005
    CROXFORD, John Robert
    Stanley Court
    Worcester Road
    SH2 6SD Sutton
    18
    Surrey
    Segretario
    Stanley Court
    Worcester Road
    SH2 6SD Sutton
    18
    Surrey
    British139724880002
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Segretario
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    LUDLEY, Susan Jane
    2nd Floor Elizabeth House
    Tilehurst
    RG31 5AL Reading
    20 School Road
    England
    Segretario
    2nd Floor Elizabeth House
    Tilehurst
    RG31 5AL Reading
    20 School Road
    England
    British58112210001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ABRAHAM, Neville Victor
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    Amministratore
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritish10579160002
    BLOWS, Neil Martin
    The Coach House
    Monkmead Lane
    RH20 2PE West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    The Coach House
    Monkmead Lane
    RH20 2PE West Chiltington
    West Sussex
    British79756510001
    BROACKES, Simon Nigel
    Flat 61 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Amministratore
    Flat 61 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    British62000870001
    CROMBLE HOLME, Cindy Lou
    Flat 2 13 St Cuthbert's Road
    NW2 3QJ London
    Amministratore
    Flat 2 13 St Cuthbert's Road
    NW2 3QJ London
    British112416450001
    CROXFORD, John Robert
    Stanley Court
    Worcester Road
    SH2 6SD Sutton
    18
    Surrey
    Amministratore
    Stanley Court
    Worcester Road
    SH2 6SD Sutton
    18
    Surrey
    United KingdomBritish139724880002
    DA COSTA, Michael Phillip
    43 Clifton Hill
    St John Wood
    NW8 0QE London
    Amministratore
    43 Clifton Hill
    St John Wood
    NW8 0QE London
    British26140900001
    GUY, Andrew Graham
    Wood Lane
    N6 5UD Highgate
    5 Ailanthus 65
    London
    Amministratore
    Wood Lane
    N6 5UD Highgate
    5 Ailanthus 65
    London
    United KingdomBritish137508780001
    HILL, Steven Alan
    62b Ridgway Place
    Wimbledon
    SW19 4SW London
    Amministratore
    62b Ridgway Place
    Wimbledon
    SW19 4SW London
    British55977430004
    HOLDER, Ian Keith
    Top Flats
    55 Lexham Gardens
    W8 5JS London
    Amministratore
    Top Flats
    55 Lexham Gardens
    W8 5JS London
    British60759970002
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Amministratore
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    United KingdomBritish2996380001
    KEANE, James
    Four Winds
    10 Burley Drive
    DE22 5JT Quarnden
    Derbyshire
    Amministratore
    Four Winds
    10 Burley Drive
    DE22 5JT Quarnden
    Derbyshire
    British25153500001
    LLOYD JONES, Gareth Victor
    50 Epirus Road
    Fulham
    SW6 7UH London
    Amministratore
    50 Epirus Road
    Fulham
    SW6 7UH London
    British45941250001
    NORLAND, Christopher Charles
    Winters Farm Witherenden Road
    TN20 6RP Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Winters Farm Witherenden Road
    TN20 6RP Mayfield
    East Sussex
    British52182980001
    RHODES, James
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    Amministratore
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    United KingdomBritish116859480001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    ROBERTS, Peter William Denby
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    Amministratore
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    EnglandBritish106538510001
    SCOTT, Richard John
    Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Fulshaw Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Fulshaw Court
    Buckinghamshire
    EnglandBritish139713290001
    SHOTTER, Philip Andrew
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    Amministratore
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    United KingdomBritish154957760001
    STANDRING, Edward John Fisher
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    Amministratore
    Cochrane Mews
    St Johns Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    EnglandBritish111618310001
    WILLIAMS, David Grey
    Orchard House
    Shootersway Lane
    HP4 3NW Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Orchard House
    Shootersway Lane
    HP4 3NW Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish33840400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RICHOUX LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Richoux Group Plc
    Cochrane Mews
    St John's Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    England
    06 apr 2016
    Cochrane Mews
    St John's Wood
    NW8 6NY London
    5-8
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies, Companies House
    Numero di registrazione03517191
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RICHOUX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge of licensed premises
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 08 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the property k/a 42A south audley street, grosvenor square, london city of westminster, t/n NGL630015. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 08 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 5-8 cochrane mews london NW8 benfit of all rights licences rent depsoits contracts deeds undertakings assigns the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 22 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/as 3 circus road st.johns wood london NW8. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 lug 1995
    Consegnato il 21 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    86 princes court brompton road knightsbridge london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture stock deed
    Creato il 30 lug 1992
    Consegnato il 11 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £850,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and all subsequent stockholders pursuant to the debenture stock deed
    Brevi particolari
    (For full details see form 395). a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 lug 1992
    Consegnato il 01 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a fixed and floating charge dated 31ST january 1989
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital (please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of goodwill
    Creato il 21 mag 1990
    Consegnato il 07 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The goodwill of any trade or business carried on upon the property k/a 171/172 piccadilly, london title no ngl 369018 42A south audley street grosvenor square london W1. Title no ngl 630015, together with all benefit & advantage of the magistrates certificates & excise licences, all fixtures or fittings (see form 395 for full details and property).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Licensed premises legal charge
    Creato il 21 mag 1990
    Consegnato il 07 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal charge over unit 7, old red lion court stratford upon avon together with the goodwill of any trade of business together with all benefit & advantage of the magistrates certificates & excise licences together with all fixtures or fittings.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 10 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 10 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 171/172 piccadilly, london W1 ground floor & basement, & sub-basement title no ngl 969018.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 10 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41, 42 & 42A south audley street, grosvenor square london W1 (ground floor & basment).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 10 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    86 princes court, brompton road, london sw 3 title no ngl 607449.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 10 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 101 high street, winchester, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit
    Creato il 21 giu 1983
    Consegnato il 22 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 21/6/83 and this charge
    Brevi particolari
    £4,250 deposited by the company with its landlords as security aforesaid (see doc M27 for furhter details).
    Persone aventi diritto
    • The London County Freehold and Leasehold Properties Limited.
    Transazioni
    • 22 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RICHOUX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 gen 2021Inizio dell'amministrazione
    13 apr 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Christopher Robert Pole
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0