CHIEFTAIN GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHIEFTAIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01455149 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere
- Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni
- Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni
Dove si trova CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o C/O REDHALL GROUP PLC Unit 3 Calder Close WF4 3BA Wakefield West Yorkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHIEFTAIN GROUP P.L.C. | 11 ago 1987 | 11 ago 1987 |
| CHIEFTAIN INSULATION LIMITED | 18 ott 1979 | 18 ott 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014551490013, creata il 24 gen 2019 | 46 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 014551490012, creata il 24 gen 2019 | 45 pagine | MR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Russell David Haworth il 10 gen 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Wayne Pearson come amministratore in data 03 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Russell David Haworth come amministratore in data 03 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Philip Comer il 09 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Kelly come segretario in data 01 lug 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Philip Comer come segretario in data 02 lug 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Kelly come amministratore in data 29 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Philip Comer come amministratore in data 02 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Brierley come amministratore in data 31 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Wayne Pearson come amministratore in data 19 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA in data 05 ago 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMER, Simon Philip | Segretario | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 248241940001 | |||||||
| COMER, Simon Philip | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 206088760003 | |||||
| HAWORTH, Russell David | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 201533400002 | |||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Segretario | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| KELLY, Christopher John | Segretario | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187596050001 | |||||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Segretario | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | British | 134974090001 | ||||||
| ADAMS, Laurence George | Amministratore | 15 Rolley Way Castlefields NE42 5FH Prudhoe Northumberland | England | British | 87979230002 | |||||
| BRIERLEY, Philip | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 54808010002 | |||||
| CORBISHLEY, Michael | Amministratore | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| COULSON, William Andrew | Amministratore | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| CUTCHIE, Anthony William | Amministratore | 68 Davison Avenue NE26 3SU Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 45955990001 | |||||
| DAWSON, John Frederic | Amministratore | Park Dale LS29 6LW Menston 1 West Yorkshire | British | 8366360002 | ||||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Amministratore | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| FLEETWOOD, Christopher John | Amministratore | 4 The Meadows DL10 7DU Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 1718030001 | |||||
| FOSTER, Robert Simon | Amministratore | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford Devon | England | British | 134973970001 | |||||
| GOODENOUGH, Anthony | Amministratore | Bakery Drive Grange Park TS19 0SN Stockton-On-Tees 1 Cleveland | England | British | 139196050001 | |||||
| IREDALE, George Henry Cecil | Amministratore | Redmays 14 North Lodge Lambton Park DH3 4AZ Chester Le Street County Durham | British | 141871680001 | ||||||
| JACKSON, David James | Amministratore | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 62867720010 | |||||
| JESTER, Tony | Amministratore | 6 Cranbourne Drive TS10 2SP Redcar Cleveland | England | British | 107694130001 | |||||
| JOHNSON, Raymond | Amministratore | 1 Colville Court DH9 6UW East Stanley County Durham | England | British | 266049760001 | |||||
| KELLY, Christopher John | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 188444350001 | |||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Amministratore | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | England | British | 134974090001 | |||||
| MARTINDALE, Stephen Richard | Amministratore | Am Waldeck 14 FOREIGN 34537 Bad Wildungen Germany | Germany | British | 77194110002 | |||||
| O'KANE, John Peter | Amministratore | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 106172200001 | |||||
| OLIVER, Malcolm William | Amministratore | 12c Burtree Lane DL3 0XQ Darlington County Durham | England | British | 143300760001 | |||||
| PEARSON, Wayne | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 212154420001 | |||||
| PENDLETON, Alan George | Amministratore | 12 Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | British | 30248370001 | ||||||
| PRICE, Anthony Hall | Amministratore | Irton CA19 1UZ Holmrook Mecklin Cumbria | England | British | 134973860001 | |||||
| SHIPPEN, Kenneth | Amministratore | 14 Rectory Park NE61 2SZ Morpeth Northumberland | British | 67917400001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Amministratore | c/o C/O Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | 58727820002 | |||||
| TAYLOR, William Platt | Amministratore | Ryton House Mainsforth DL17 9AA Ferryhill County Durham | British | 7203810001 | ||||||
| WARDLE, Peter | Amministratore | 14 Brandling Park Jesmond NE2 4RR Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 73518260002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redhall Group Plc | 06 apr 2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CHIEFTAIN GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 24 gen 2019 Consegnato il 29 gen 2019 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 gen 2019 Consegnato il 29 gen 2019 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 dic 2015 Consegnato il 02 gen 2016 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 gen 2011 Consegnato il 28 gen 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 apr 2009 Consegnato il 09 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 28 mag 2004 Consegnato il 17 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 09 set 1996 Consegnato il 12 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 ago 1996 Consegnato il 13 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 02 nov 1994 Consegnato il 11 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 26 ago 1992 Consegnato il 09 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 20 gen 1988 Consegnato il 05 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 giu 1985 Consegnato il 11 giu 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 21 set 1984 Consegnato il 28 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0