CHIEFTAIN GROUP LIMITED

CHIEFTAIN GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHIEFTAIN GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01455149
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere
    • Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni
    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O REDHALL GROUP PLC
    Unit 3 Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHIEFTAIN GROUP P.L.C.11 ago 198711 ago 1987
    CHIEFTAIN INSULATION LIMITED18 ott 197918 ott 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 014551490013, creata il 24 gen 2019

    46 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 014551490012, creata il 24 gen 2019

    45 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Russell David Haworth il 10 gen 2019

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Wayne Pearson come amministratore in data 03 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Russell David Haworth come amministratore in data 03 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Philip Comer il 09 ago 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come segretario in data 01 lug 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come segretario in data 02 lug 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come amministratore in data 29 giu 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come amministratore in data 02 lug 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Philip Brierley come amministratore in data 31 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wayne Pearson come amministratore in data 19 mar 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA in data 05 ago 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2016

    Stato del capitale al 29 apr 2016

    • Capitale: GBP 450,925
    SH01

    Chi sono gli amministratori di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    248241940001
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish206088760003
    HAWORTH, Russell David
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish201533400002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187596050001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Segretario
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    British134974090001
    ADAMS, Laurence George
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    Amministratore
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    EnglandBritish87979230002
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish54808010002
    CORBISHLEY, Michael
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    Amministratore
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    EnglandBritish101553180002
    COULSON, William Andrew
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36723860001
    CUTCHIE, Anthony William
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish45955990001
    DAWSON, John Frederic
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    British8366360002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    FLEETWOOD, Christopher John
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish1718030001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    Amministratore
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    EnglandBritish134973970001
    GOODENOUGH, Anthony
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    Amministratore
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    EnglandBritish139196050001
    IREDALE, George Henry Cecil
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    British141871680001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JESTER, Tony
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    Amministratore
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    EnglandBritish107694130001
    JOHNSON, Raymond
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    Amministratore
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    EnglandBritish266049760001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish188444350001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Amministratore
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    EnglandBritish134974090001
    MARTINDALE, Stephen Richard
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    Amministratore
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    GermanyBritish77194110002
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    Amministratore
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    United KingdomIrish106172200001
    OLIVER, Malcolm William
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish143300760001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish212154420001
    PENDLETON, Alan George
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    British30248370001
    PRICE, Anthony Hall
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    Amministratore
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    EnglandBritish134973860001
    SHIPPEN, Kenneth
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    British67917400001
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish58727820002
    TAYLOR, William Platt
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Amministratore
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    British7203810001
    WARDLE, Peter
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish73518260002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHIEFTAIN GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 apr 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione263995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CHIEFTAIN GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 gen 2019
    Consegnato il 29 gen 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Downing LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 gen 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 gen 2019
    Consegnato il 29 gen 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • (1) 1798 Volantis Fund Limited and (2) 1798 Volantis Catalyst Fund Limited
    Transazioni
    • 29 gen 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 dic 2015
    Consegnato il 02 gen 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alphagen Volantis Catalyst Fund Limited
    • Alphagen Volantis Fund Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 21 gen 2011
    Consegnato il 28 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2009
    Consegnato il 09 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 17 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 set 1996
    Consegnato il 12 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 1996
    Consegnato il 13 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 02 nov 1994
    Consegnato il 11 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 26 ago 1992
    Consegnato il 09 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 gen 1988
    Consegnato il 05 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1985
    Consegnato il 11 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 set 1984
    Consegnato il 28 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0