OAKDALE BAKERIES LIMITED

OAKDALE BAKERIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOAKDALE BAKERIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01461281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    • (1581) /

    Dove si trova OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOLLY BAKER LIMITED(THE)15 nov 197915 nov 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 feb 2011

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 gen 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2010

    8 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    4 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 gen 2010

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 lug 2009

    6 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 lug 2008

    22 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività

    12 pagine2.16B

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    38 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    20 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di OAKDALE BAKERIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEVLIN, Paul John
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    Segretario
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    British113889280001
    DEVLIN, Paul John
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    Amministratore
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    United KingdomBritish113889280001
    HOLEBROOK, Maureen
    22, Chestnut Avenue
    Crosby
    L23 2SZ Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    22, Chestnut Avenue
    Crosby
    L23 2SZ Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish113892420001
    KINGSLEY, Desmond Anthony
    Middleton House
    2 Redmayne Square
    YO32 5YN Strensal
    North Yorkshire
    Amministratore
    Middleton House
    2 Redmayne Square
    YO32 5YN Strensal
    North Yorkshire
    British99683290001
    CAPEL, Lesley
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    British10077150001
    SAVILLE, Selwyn Michael
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    British47615480001
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Amministratore
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritish93024670001
    CAPEL, Lesley
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    British10077150001
    CAPEL, Marshall Philip, Mr.
    Birkby Grange Farm
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Birkby Grange Farm
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish154919490001
    DICKINSON, Michael John
    Woodsome House Woodsome Park
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodsome House Woodsome Park
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    West Yorkshire
    British10819590001
    FREW, Robert Alexander
    Crayke Hall
    Church Hill, Crayke
    YO61 4TA York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crayke Hall
    Church Hill, Crayke
    YO61 4TA York
    North Yorkshire
    EnglandBritish71199280001
    GARDNER, Barrie Howard
    Roe Lodge
    Sowerby Row,Southwaite
    CA4 0QH Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Roe Lodge
    Sowerby Row,Southwaite
    CA4 0QH Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritish80605980001
    LEE, Ian Edwin
    6 Brookhill Grove
    LS17 8QF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Brookhill Grove
    LS17 8QF Leeds
    West Yorkshire
    British99683250001
    PAUL, Gilson
    Clarendon House
    38 Greenstile Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    Amministratore
    Clarendon House
    38 Greenstile Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    British104511560001
    SAVILLE, Selwyn Michael
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish47615480001
    YOUNG, Janette
    7 Parc Mont
    9 Park Avenue
    LS8 2WE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Parc Mont
    9 Park Avenue
    LS8 2WE Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish112348660001

    OAKDALE BAKERIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 24 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at ogden road shaw lane industrial estate doncaster t/no SYK213585, land at ogden road shaw lane industrial estate doncaster t/no SYK226329, f/h land at cole lane new springs aspull greater manchester t/no GM619850. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Islandsbanki Hf., as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties(Thesecurity Agent)
    Transazioni
    • 24 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 2004
    Consegnato il 24 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit BT500/1 ogden road shaw lane industrial estate doncaster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 2003
    Consegnato il 18 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings shortly known as 500/512 ogden road, shaw lane industrial estate, doncaster t/n SYK226329.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 2003
    Consegnato il 18 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings shortly known as bakery and offices at cale lane, aspull, wigan, greater manchester t/n GM619850.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 02 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 10 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at cale lane wigan lancashire t/no: GM619850. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 08 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items as listed on the schedule attached. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 03 ott 2002
    Consegnato il 03 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule :- intel piv-2GHZ midi tower with 15" svga monitor, compaq ML370 piii-1.4 Ghz dual processor & raid, controller (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2000
    Consegnato il 11 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 04 apr 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 ago 1997
    Consegnato il 05 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge:-(i) all receivables including their related rights (as both terms are defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement.(ii) all amounts of indebtedness including their related rights now or at any time hereafter owing or becoming due to the company.floating charge such monies as the company may from time to time receive in respect of the other trade debts as shall from time to time stand released from the fixed charge thereon.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 giu 1996
    Consegnato il 19 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things as specified in form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 19 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 1995
    Consegnato il 01 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north east side of shaw lane, doncaster, south yorkshire t/no: SYK226329. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 mag 1995
    Consegnato il 16 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 1995
    Consegnato il 04 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises situate on the north east side of shaw lane doncaster. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 10 ott 1990
    Consegnato il 31 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 3.11.86
    Brevi particolari
    All right title and interest arising out of a receivables financing agreement dated 7.6.90 and all book debts and other debts the subject of the charged agreements.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 giu 1990
    Consegnato il 08 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a discounting agreement dated 7.6.90
    Brevi particolari
    All the book and other debts due to the company by way of a first fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 08 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 1988
    Consegnato il 18 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north east side of ogden road shaw lane industrial estate doncaster S. yorkshire T.N. syk 190933.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1986
    Consegnato il 13 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold plot of land situate off thorn road, doncaster, south yorkshire which forms part of the english industrial estate corporation shaw lane industrial estate.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 27 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 nov 1986
    Consegnato il 12 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or marshalls bakery limited on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 27 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge registered pursuant to an order of court dated 2 feb 1984.
    Creato il 01 lug 1983
    Consegnato il 22 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 2 march 1984
    Brevi particolari
    L/H factory and land known as site number bt 500/12 shaw lane industrial estate doncaster, south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The English Industrial Estates Corporation
    Transazioni
    • 22 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 08 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OAKDALE BAKERIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 gen 2007Inizio dell'amministrazione
    28 lug 2008Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Myles Anthony Halley
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    28 lug 2008Inizio della liquidazione
    02 giu 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Myles Anthony Halley
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Mark Granville Firmin
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0