RADIO AIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRADIO AIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01466839
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RADIO AIRE LIMITED?

    • Attività di produzione di programmi televisivi (59113) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova RADIO AIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RADIO AIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WEST YORKSHIRE BROADCASTING P.L.C.31 dic 198031 dic 1980
    TRUSHELFCO (NO. 266) LIMITED13 dic 197913 dic 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di RADIO AIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per RADIO AIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 03 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deidre Ann Ford il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Bauer Group Secretariat Limited il 25 set 2018

    1 pagineCH04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deidre Ann Ford il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di RADIO AIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish119137220004
    DEWHURST, Anthony John
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    Segretario
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    British3275560001
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Segretario
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    GILES, Nicholas David Martin
    8 Pyms Gardens
    Abbotsley
    PE19 6UR St Neots
    Cambs
    Segretario
    8 Pyms Gardens
    Abbotsley
    PE19 6UR St Neots
    Cambs
    British85529870001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Segretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    HOGG, Marianne Lisa
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    Segretario
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    British101383970002
    NAREBOR, Torugbene Eniyekeye
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    Segretario
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    British120147010002
    SEDDON, Philip John
    Oak Tree Barn
    Dean Height Waterfoot
    BB4 9SA Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    Oak Tree Barn
    Dean Height Waterfoot
    BB4 9SA Rossendale
    Lancashire
    British31928420002
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    SISEC LIMITED
    Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    21
    Segretario
    Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    21
    128265760001
    BALDWIN, John Stuart
    54 Plimsoll Way
    HU9 1PR Hull
    Yorkshire
    Amministratore
    54 Plimsoll Way
    HU9 1PR Hull
    Yorkshire
    British84117230001
    BAWDEN, Michael
    2 Waterside Court
    LS13 1RF Leeds
    Amministratore
    2 Waterside Court
    LS13 1RF Leeds
    British71393470002
    CAPLIN, Stanley Bobbie
    82 Sandmoor Lane
    LS17 7EA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    82 Sandmoor Lane
    LS17 7EA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish7676330001
    CONNOLLY, Michael Joseph
    Tower House Woodlands Grove
    Grimsargh
    PR2 5LB Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Tower House Woodlands Grove
    Grimsargh
    PR2 5LB Preston
    Lancashire
    British3275550001
    DEWHURST, Anthony John
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish3275560001
    DYSON, Elizabeth Ann
    9 Hopefield Chase
    Meadow Walk Rothwell
    LS26 0XX Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    9 Hopefield Chase
    Meadow Walk Rothwell
    LS26 0XX Leeds
    Yorkshire
    British75073980001
    EASTWOOD, Tracy
    6 Delph Hill Road
    HX2 7EL Halifax
    West Yroks
    Amministratore
    6 Delph Hill Road
    HX2 7EL Halifax
    West Yroks
    British79549470001
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish40591070005
    EMBLEY, Deborah Jayne
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    Amministratore
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    EnglandBritish75933680001
    FAIRBURN, Paul Martin
    92 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    92 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JF Leeds
    West Yorkshire
    British43039880001
    GREGORY, Shaun
    3 Periwood Avenue
    S8 0HY Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    3 Periwood Avenue
    S8 0HY Sheffield
    Yorkshire
    British65670070001
    HICKS, James Frederick
    1 Gascoigne Court
    Barwick In Elmet
    LS15 4NY Leeds
    Amministratore
    1 Gascoigne Court
    Barwick In Elmet
    LS15 4NY Leeds
    British67878790001
    KING, Stephen James
    25 Firbeck Road
    LS23 6NE Bramham
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Firbeck Road
    LS23 6NE Bramham
    West Yorkshire
    British72692220001
    LANDEY, Phillipa Joy
    The Manor House
    LS4 3EQ Thorne
    Yorkshire
    Amministratore
    The Manor House
    LS4 3EQ Thorne
    Yorkshire
    British30063700001
    MCCLUSKEY, Brian
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    Amministratore
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    British68223140002
    MCPARTLAND, Peter Thomas
    33 Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    33 Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    North Yorkshire
    British31928390001
    MOORHOUSE, Adrian
    8 Brookland Park Crescent
    Roundhay
    LS8 1HX Leeds
    Amministratore
    8 Brookland Park Crescent
    Roundhay
    LS8 1HX Leeds
    British47957320002
    O'HARA, John
    2a Langdale Road
    Wallasey
    L45 0LT Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    2a Langdale Road
    Wallasey
    L45 0LT Wirral
    Merseyside
    Irish57014550001
    ORSON, John Whitfield
    24 Stanhope Avenue
    Horsforth
    LS18 5AR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Stanhope Avenue
    Horsforth
    LS18 5AR Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish122378470001
    RIDSDALE, Robert Peter
    Wrayton Hall
    Wrayton
    LA6 2QU Carnforth
    Lancashire
    Amministratore
    Wrayton Hall
    Wrayton
    LA6 2QU Carnforth
    Lancashire
    United KingdomBritish41325940004
    RILEY, Philip Stephen
    6 New Farmers Hill
    Woodlesford
    LS28 8PS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 New Farmers Hill
    Woodlesford
    LS28 8PS Leeds
    West Yorkshire
    English38673360001
    SCHOONMAKER, Timothy
    62 Wimpole Street
    W1G 8AJ London
    Amministratore
    62 Wimpole Street
    W1G 8AJ London
    EnglandAmerican103614790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RADIO AIRE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01394141
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RADIO AIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 giu 1990
    Consegnato il 19 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 1986
    Consegnato il 13 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the property comprised in title no wyk 245547 inc. All fixtures & fittings plant & machinery but excluding all broadcast technical equipment and the air conditioning plant.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 ago 1983
    Consegnato il 23 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc. M37). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1981
    Consegnato il 23 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and premises at kirkstall road, leeds with all fixtures and contracting an area of O.476 rectares or thereabouts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 dic 1980
    Consegnato il 05 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed & floating charge on undertaaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital (please see doc M35).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0