TGA CHAPMANS LIMITED

TGA CHAPMANS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTGA CHAPMANS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01470900
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di TGA CHAPMANS LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova TGA CHAPMANS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Brazennose House
    Lincoln Square
    M2 5BL Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TGA CHAPMANS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    T.G.A. LIMITED26 nov 198226 nov 1982
    TEAM GRAPHIC ARTS LIMITED03 gen 198003 gen 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di TGA CHAPMANS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2003
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2004
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TGA CHAPMANS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 set 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TGA CHAPMANS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per TGA CHAPMANS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    6 pagineAC92
    R4GZTZXC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Varie

    Sec/state release of liquidator
    1 pagineMISC

    Varie

    O/Court replacement liquidator
    14 pagineMISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Varie

    S/S cert release of liquidator
    1 pagineMISC

    Varie

    O/Court removal of liquidator
    10 pagineMISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    4 pagine155(6)a

    Avviso di costituzione del Comitato di Liquidazione

    2 pagine4.48

    Dichiarazione delle attività

    31 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2002

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TGA CHAPMANS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HYAMS, Anna
    83 Savile Park Road
    HX1 2XR Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    83 Savile Park Road
    HX1 2XR Halifax
    West Yorkshire
    AustrianFinancial Controller85399150001
    HYAMS, Michael Howard
    83 Savile Park Road
    HX1 2XR Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    83 Savile Park Road
    HX1 2XR Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishExhibition Consultant80586880001
    MARSH, Robert
    13 Farringdon Grove
    Wibsey
    BD6 2LW Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    13 Farringdon Grove
    Wibsey
    BD6 2LW Bradford
    West Yorkshire
    BritishExhibition Contractor15208210001
    ALEXANDER, John
    Pennine View
    3 Overdale Place
    ST13 8LZ Leek
    Staffordshire
    Segretario
    Pennine View
    3 Overdale Place
    ST13 8LZ Leek
    Staffordshire
    BritishAccountant103671730001
    BLOOMFIELD, Richard Jeffery
    6 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    6 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant51056360001
    GALPERT, Simeon
    Gairnside House
    Gate End
    HA6 3QG Northwood
    Middlesex
    Segretario
    Gairnside House
    Gate End
    HA6 3QG Northwood
    Middlesex
    British63842730001
    JOHNSON, Christopher David
    10 Thorpeside Close
    TW18 3NZ Staines
    Middlesex
    Segretario
    10 Thorpeside Close
    TW18 3NZ Staines
    Middlesex
    British34625800001
    LEE, Lesley Christine
    78 Lee Green
    WF14 0AG Mirfield
    West Yorkshire
    Segretario
    78 Lee Green
    WF14 0AG Mirfield
    West Yorkshire
    British18116560001
    MORLEY, Kevin Thomas, Professor
    Crosby House
    Red Copse Lane Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    Segretario
    Crosby House
    Red Copse Lane Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    BritishCompany Director13874040001
    ROWLAND, John Percival
    49 Ediva Road
    DA13 0NA Meopham
    Kent
    Segretario
    49 Ediva Road
    DA13 0NA Meopham
    Kent
    British34533150001
    ALEXANDER, John
    Pennine View
    3 Overdale Place
    ST13 8LZ Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    Pennine View
    3 Overdale Place
    ST13 8LZ Leek
    Staffordshire
    EnglandBritishAccountant103671730001
    BARRACLOUGH, Anthony David
    Homeleigh 56 Deighton Lane
    WF17 7EU Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Homeleigh 56 Deighton Lane
    WF17 7EU Batley
    West Yorkshire
    BritishProduction Director7647480001
    BARRETT, Keith
    Charnock Crabtree Green
    Collingham
    LS22 5AB Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Charnock Crabtree Green
    Collingham
    LS22 5AB Wetherby
    West Yorkshire
    BritishFinance Director26591140001
    BLOOMFIELD, Richard Jeffery
    6 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    6 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant51056360001
    DEWHIRST, Kenneth Frederick Thompson
    Hollyhirst 14 Park Drive West
    WF14 9NQ Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hollyhirst 14 Park Drive West
    WF14 9NQ Mirfield
    West Yorkshire
    BritishExhibition Contractor14922660001
    GALPERT, Simeon
    Gairnside House
    Gate End
    HA6 3QG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Gairnside House
    Gate End
    HA6 3QG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCorporate Executive63842730001
    HAMPSON, John
    14 Terrace Row
    Billington
    BB7 9NX Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    14 Terrace Row
    Billington
    BB7 9NX Clitheroe
    Lancashire
    BritishAdvertising Executive46105320002
    HOWARD, Jane Alison
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    Amministratore
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    EnglandBritishManaging Director51904570002
    HOWLETT, Ronald
    The Old Schoolhouse
    Micklefield Lane
    LS19 6AU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Schoolhouse
    Micklefield Lane
    LS19 6AU Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccount Executive73996510001
    HOWLETT, Ronald
    The Old Schoolhouse
    Micklefield Lane
    LS19 6AU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Schoolhouse
    Micklefield Lane
    LS19 6AU Leeds
    West Yorkshire
    BritishAdvertising Executive73996510001
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director83713020001
    MAKULSKI, Jerzy Leon
    The Grange Fallow End
    Pottersheath Road
    AL6 9ST Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Grange Fallow End
    Pottersheath Road
    AL6 9ST Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50680300001
    MCCLURE, Neil James
    Rotherfield House
    Colliers Lane Peppard Common
    RG9 5LT Henley On Thames
    Oxon
    Amministratore
    Rotherfield House
    Colliers Lane Peppard Common
    RG9 5LT Henley On Thames
    Oxon
    BritishCompany Director76457860001
    MORLEY, Kevin Thomas, Professor
    Crosby House
    Red Copse Lane Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    Amministratore
    Crosby House
    Red Copse Lane Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    EnglandBritishCompany Director13874040001
    MULVEY, Michael
    2 Wool Road
    Dobcross Saddleworth
    OL3 5NS Oldham
    Lancshire
    Amministratore
    2 Wool Road
    Dobcross Saddleworth
    OL3 5NS Oldham
    Lancshire
    United KingdomBritishChairman37926930001
    POOLE, Michael David
    47 Ashtofts Mount
    LS20 9DB Guisley
    Leeds
    Amministratore
    47 Ashtofts Mount
    LS20 9DB Guisley
    Leeds
    BritishAccount Director18116580002
    REDFERN, John William Irvine
    Flat 3
    512 Wilmslow Road Withington
    M20 4BT Manchester
    Amministratore
    Flat 3
    512 Wilmslow Road Withington
    M20 4BT Manchester
    EnglandBritishManager41088690001
    SMITH, Steven Miles
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Amministratore
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    GuernseyBritishChartered Accountant62484110002
    SMITH, Steven Miles
    8 Madingley Court
    Willoughby Road
    TW1 2QN Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Madingley Court
    Willoughby Road
    TW1 2QN Twickenham
    Middlesex
    BritishChartered Accountant62484110001

    TGA CHAPMANS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 22 set 2000
    Consegnato il 28 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re tga chapmans limited-high interest business account number 50228001. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 nov 1992
    Consegnato il 26 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 lug 1990
    Consegnato il 09 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on book debts
    Creato il 19 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TGA CHAPMANS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2003Inizio della liquidazione
    10 mar 2008Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lindsey J Cooper
    Baker Tilly
    Brazennose House
    M2 5BL Lincoln Square
    Manchester
    Praticante
    Baker Tilly
    Brazennose House
    M2 5BL Lincoln Square
    Manchester
    David Leighton Cockshott
    2 Whitehall Quay
    Leeds
    LS1 4HG
    Praticante
    2 Whitehall Quay
    Leeds
    LS1 4HG
    Stephen Mark Quinn
    Baker Tilly
    Brazennose House
    M2 5BL Lincoln Square
    Manchester
    Praticante
    Baker Tilly
    Brazennose House
    M2 5BL Lincoln Square
    Manchester
    Adrian David Allen
    Baker Tilly
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0