SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01470966
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VEXBERRY LIMITED03 gen 198003 gen 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 gen 2012

    13 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 gen 2012

    13 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 lug 2011

    27 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    7 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    65 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor Building 2610 the Quadrant Aztec West Bristol BS32 4TR in data 09 feb 2011

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    26 pagineAA

    legacy

    10 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 15 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 lug 2010

    Stato del capitale al 20 lug 2010

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Abu-Haris Shafi il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nikolai Kesting il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Willoughby Corporate Secretarial Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    25 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    80
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02691637
    68522760005
    KESTING, Nikolai
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    GermanyGerman137231520001
    SHAFI, Abu-Haris
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish137231430002
    ATKINSON, Paul Robert
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    Segretario
    29 Longlands Road
    DA15 7LU Sidcup
    Kent
    British5884180001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Segretario
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    ATKINSON, Paul Robert
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    Amministratore
    4 Victoria Road
    DA15 7HD Sidcup
    Kent
    EnglandBritish5884180002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritish50777030001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12204760003
    DAUMANN, Christian
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    Amministratore
    Gam-Bischefsheim
    Rulaenderweg 11
    55296
    Germany
    German132789860001
    DEAKIN, Janice
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    Amministratore
    Field Barn
    Broad Road
    IP20 0AZ Alburgh
    Norfolk
    EnglandBritish238355920001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Amministratore
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    GLOVER, Richard Gordon Finlay
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    Amministratore
    86 Grange Road
    Ealing
    W5 3PJ London
    EnglandBritish5884200002
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HEWITT, Alison Deborah
    Hewitt
    Hough Hall Newcastle Road Hough
    CW5 2JG Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Hewitt
    Hough Hall Newcastle Road Hough
    CW5 2JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish66782800005
    LOVELAND-COOPER, Philip Stephen
    33 Markville Gardens
    CR3 6RG Caterham
    Surrey
    Amministratore
    33 Markville Gardens
    CR3 6RG Caterham
    Surrey
    British42745300001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    MASSEY, Paul Ashley
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Amministratore
    20 Elwill Way
    Park Langley
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish24243460001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    British38351740003
    SPICKER, Richard Harold
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    Amministratore
    Honeysuckle Barn
    Brands Lane, Felthorpe
    NR10 4EA Norwich
    EnglandBritish120021510001
    TODD, David
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    64 Long Road
    Framingham Earl
    NR14 7RZ Norwich
    Norfolk
    British70494790001
    WALDEN, Jonathan Kim
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish3809630002

    SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 lug 2010
    Consegnato il 22 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 feb 2009
    Consegnato il 13 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rac PLC (Noteholder)
    Transazioni
    • 13 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 mag 1993
    Consegnato il 07 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from bsm group limited to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the facility agreement dated 13/04/90
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security.
    Creato il 20 apr 1990
    Consegnato il 30 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the shop premises numbers thirty-two morrison street in the city and parish of edinburgh and county of midlothian.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security presented registration in scotland on 20-4-90
    Creato il 13 apr 1990
    Consegnato il 03 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the second southmost of the four shops on the ground floor of the tenement k/a 39 causeyside street paisley, in the burgh of paisley and county of renfrew.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 20-4-90.
    Creato il 13 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole that shop situated at and forming no.1030 Pollockshaws rd glasgow forming part of the ground floor of the tenement at N0.1028 - 1034 pollockshaws rd aforesaid and erected as the area of ground extending to 1365 square yds and 2/9TH parts of a square yd all lying in the county of the barony & regality of glasgow.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 apr 1990
    Consegnato il 20 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or from the group (as defined in the charge). To the chargee. As agent and trustee for the secured parties (as defined in the charge) under the terms of the facilities agreement dated 13TH april 1990, the interest & rate protection agreements (as defined in the facilities agreement) and the guarantee and debenture.
    Brevi particolari
    (For full details see form M395 reference M242L).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1981
    Consegnato il 10 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A ya specific equitable charge over all f/h & l/h properties fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets both present & further including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 18 giu 1974
    Acquisito il 27 mar 1981
    Consegnato il 08 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,300,18
    Brevi particolari
    Various properties as described in doc M18. All estates & interest in any f/h or l/h property, all stocks shares or other securities. Goodwill, undertaking & all other property & assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 18 giu 1974
    Acquisito il 27 mar 1981
    Consegnato il 08 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,046.83
    Brevi particolari
    Various properties as described in doc M17. All estates & interest in any f/h or l/h property, all stocks shares or other securities. Goodwill, undertaking & all other property & assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1981Registrazione di un'ipoteca

    SCORPIO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2011Inizio dell'amministrazione
    25 gen 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0