CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01471805
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HILLINGS INVESTMENTS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    SLICKBOROUGH LIMITED08 gen 198008 gen 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy Saunders come amministratore in data 12 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2016

    Stato del capitale al 26 mag 2016

    • Capitale: GBP 442
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The White House 10 Clifton York YO30 6AE

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a The White House 10 Clifton York YO30 6AE

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 14 mar 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2015

    Stato del capitale al 18 mag 2015

    • Capitale: GBP 442
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robin Leslie Phillips il 16 mag 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mag 2014

    Stato del capitale al 21 mag 2014

    • Capitale: GBP 442
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Christopher Paul Martin il 16 mag 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Christopher Paul Martin il 16 mag 2014

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da , 305 Grays Inn Road, London, WC1X 8QR, United Kingdom in data 16 mag 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Christopher Paul Martin come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Christopher Paul
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    British178775380001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director108543490005
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Segretario
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary157947720001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Segretario
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    British15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Segretario
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    BritishCompany Director47952140001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Segretario
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    BUSTIN, Desmond John
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector31260040001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Amministratore
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritishDirector76512840002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Amministratore
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishDirector87647990001
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Amministratore
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishCompany Director87647990001
    HUNT, Alan Edward
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector74704080001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishChairman46176700002
    SAMBROOK, Christiane Marie
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Anglo-FrenchProperty Management36197920001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Amministratore
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    BritishDirector15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director47952140001
    SELL, Karen Elizabeth
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishAccounts Manager36197970001
    STAPLEFORD MANAGEMENT LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Amministratore
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    48564730001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Touchstone Corporate Property Services Limited
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    06 apr 2016
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England & Wales
    Numero di registrazione4695692
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 feb 2008
    Consegnato il 21 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 21 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 13 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transazioni
    • 13 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of intellectual property rights
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - castle estates dawson road mount farm milton keynes t/no BM245239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2006
    Consegnato il 30 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Venture Managers Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land on the south side of dawson road mount farm industrial estate central milton keynes t/n BM245239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 2002
    Consegnato il 20 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 31 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property 8 aymer house new church rd hove. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit account agreement
    Creato il 11 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the agreement
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the rent deposit account including all interest.
    Persone aventi diritto
    • Joy Frances Gooding
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 15 ago 1996
    Consegnato il 27 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 giu 1993
    Consegnato il 14 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or castle estates (milton keynes) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 dic 1992
    Consegnato il 05 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The whole or any part of the rents or other money due from the company to the chargee under a lease dated 21/12/92
    Brevi particolari
    A separate designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society opened or to be opened in the name of the chargee having an initial balance of £1,482.50 together with all sums subsequently paid into this said account.
    Persone aventi diritto
    • Manteca Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental deposit
    Creato il 25 mar 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to manteca limited under a lease dated 25/03/92 and this deed
    Brevi particolari
    All the interest of the company in the amount from time to time standing to the credit of a designated interest lending account.
    Persone aventi diritto
    • Manteca Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 17 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 1981
    Consegnato il 04 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises situate at and known as number 30 bridge street olney. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0