CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01471805 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 80 Cheapside EC2V 6EE London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HILLINGS INVESTMENTS LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
SLICKBOROUGH LIMITED | 08 gen 1980 | 08 gen 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Saunders come amministratore in data 12 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The White House 10 Clifton York YO30 6AE | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a The White House 10 Clifton York YO30 6AE | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 14 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robin Leslie Phillips il 16 mag 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Christopher Paul Martin il 16 mag 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Christopher Paul Martin il 16 mag 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , 305 Grays Inn Road, London, WC1X 8QR, United Kingdom in data 16 mag 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Christopher Paul Martin come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Christopher Paul | Segretario | Cheapside EC2V 6EE London 80 | British | 178775380001 | ||||||
COWANS, David | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Company Director | 108543490005 | ||||
BUSTIN, Desmond John | Segretario | Church Farm House Stapleford SP3 4LN Salisbury Wiltshire | British | 31260040002 | ||||||
BUSTIN, Desmond John | Segretario | Church Farm House Stapleford SP3 4LN Salisbury Wiltshire | British | 31260040002 | ||||||
REID, Christopher | Segretario | Whitecrest Narrow Path Aspley Heath MK17 8TF Woburn Sands Buckinghamshire | British | Company Secretary | 157947720001 | |||||
SANDERS, Karen Lesley | Segretario | 28 High Street LU7 Stewkley Beds | British | 15772130001 | ||||||
SAUNDERS, Timothy | Segretario | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | Company Director | 47952140001 | |||||
REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | Segretario | Witan Court 305 Upper Fourth Street MK9 1EH Central Milton Keynes Buckinghamshire | 41052090008 | |||||||
ROXBURGH MILKINS LLP | Segretario | Merchants House North Wapping Road BS1 4RW Bristol | 114974370003 | |||||||
BUSTIN, Desmond John | Amministratore | Woodacre West Goheldon SP4 3OG Salisbury Wiltshire | British | Director | 31260040001 | |||||
CHAMPION, Mark Alistair | Amministratore | Crescent Office Park Clarks Way BA2 2AF Bath 2 | England | British | Director | 76512840002 | ||||
HOLLINGWORTH, Neil Gregory | Amministratore | Bridge House Addington MK18 2JX Winslow Bucks | United Kingdom | British | Director | 87647990001 | ||||
HOLLINGWORTH, Neil Gregory | Amministratore | Bridge House Addington MK18 2JX Winslow Bucks | United Kingdom | British | Company Director | 87647990001 | ||||
HUNT, Alan Edward | Amministratore | 37 Main Road Drayton Parslow MK17 0JR Milton Keynes Buckinghamshire | British | Director | 74704080001 | |||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Chairman | 46176700002 | ||||
SAMBROOK, Christiane Marie | Amministratore | 134 Kensington Drive Great Holm MK8 9BN Milton Keynes Bucks | Anglo-French | Property Management | 36197920001 | |||||
SANDERS, Karen Lesley | Amministratore | 28 High Street LU7 Stewkley Beds | British | Director | 15772130001 | |||||
SAUNDERS, Timothy | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 | England | British | Company Director | 47952140001 | ||||
SELL, Karen Elizabeth | Amministratore | 2 Osterley Close MK16 0EZ Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Accounts Manager | 36197970001 | |||||
STAPLEFORD MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | Witan Court 305 Upper Fourth Street Central Milton Keynes MK9 1EH Milton Keynes | 48564730001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchstone Corporate Property Services Limited | 06 apr 2016 | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 13 feb 2008 Consegnato il 21 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 giu 2006 Consegnato il 13 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of intellectual property rights | Creato il 27 giu 2006 Consegnato il 11 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 27 giu 2006 Consegnato il 11 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H - castle estates dawson road mount farm milton keynes t/no BM245239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 giu 2006 Consegnato il 11 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 giu 2006 Consegnato il 30 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 set 2002 Consegnato il 18 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold land on the south side of dawson road mount farm industrial estate central milton keynes t/n BM245239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 ago 2002 Consegnato il 20 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage deed | Creato il 21 mag 2002 Consegnato il 31 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property 8 aymer house new church rd hove. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit account agreement | Creato il 11 giu 1999 Consegnato il 17 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the agreement | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of the rent deposit account including all interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 15 ago 1996 Consegnato il 27 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 24 giu 1993 Consegnato il 14 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or castle estates (milton keynes) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 21 dic 1992 Consegnato il 05 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The whole or any part of the rents or other money due from the company to the chargee under a lease dated 21/12/92 | |
Brevi particolari A separate designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society opened or to be opened in the name of the chargee having an initial balance of £1,482.50 together with all sums subsequently paid into this said account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of rental deposit | Creato il 25 mar 1992 Consegnato il 08 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of the company to manteca limited under a lease dated 25/03/92 and this deed | |
Brevi particolari All the interest of the company in the amount from time to time standing to the credit of a designated interest lending account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 ago 1989 Consegnato il 17 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 feb 1981 Consegnato il 04 feb 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H premises situate at and known as number 30 bridge street olney. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0