YAXLEY SPP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYAXLEY SPP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01473781
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YAXLEY SPP LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova YAXLEY SPP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    66 Clifton Street
    EC2A 4HB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YAXLEY SPP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELECO (SPP) LIMITED04 giu 201304 giu 2013
    STRAMIT PANEL PRODUCTS LIMITED03 apr 201203 apr 2012
    ELECO TIMBER FRAME LIMITED25 gen 200725 gen 2007
    ELECO BUILDING COMPONENTS LIMITED08 ago 200608 ago 2006
    STRAMIT INDUSTRIES LIMITED21 lug 198721 lug 1987
    STRAMIT INDUSTRIES (UK) LIMITED 31 dic 198031 dic 1980
    KILCOTE LIMITED17 gen 198017 gen 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di YAXLEY SPP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per YAXLEY SPP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rinvio della dissoluzione

    1 pagineL64.04

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed eleco (spp) LIMITED\certificate issued on 07/03/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 mar 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 mar 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2013

    Stato del capitale al 16 dic 2013

    • Capitale: GBP 170,000
    SH01

    Cessazione della carica di Matthew Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed stramit panel products LIMITED\certificate issued on 04/06/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 giu 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 mag 2013

    RES15
    change-of-name04 giu 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAAMD

    Nomina di Ivor Ashley Barton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ivor Barton come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ivor Barton come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed eleco timber frame LIMITED\certificate issued on 03/04/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 apr 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 03 apr 2012

    RES15
    change-of-name03 apr 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Matthew Lloyd Turner come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Slater come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Fugaccia come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Ivor Ashley Barton come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Graham Neil Spratling come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    12 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di YAXLEY SPP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    Segretario
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    British174082530001
    SPRATLING, Graham Neil
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Mall
    Park Street
    AL2 2HT St Albans
    3c
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishAccountant153162830001
    BARTON, Ivor Ashley
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British15818320006
    CRAVEN, Timothy Asgill
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    Segretario
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    British20737780001
    GRAVETT, Philip James
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    Ellerslie Crawley End
    Chrishall
    SG8 8QJ Royston
    Hertfordshire
    British36746090001
    HOLDCROFT, Laurence Nigel
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    71 Fanshawe Crescent
    SG12 0AR Ware
    Hertfordshire
    British58539950002
    HOPKINS, Nigel Antony
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    9 Norton Leys
    Wavendon Gate
    MK7 7TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75324110002
    TSAPPIS, Neil John Alfred
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    Segretario
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    British49019640001
    AMOS, Robert
    Thirsville
    The Street
    IP21 5DX Horham
    Suffolk
    Amministratore
    Thirsville
    The Street
    IP21 5DX Horham
    Suffolk
    BritishWorks Director20737790001
    BARTON, Ivor Ashley
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    Amministratore
    Bluebell Close
    HP1 2DH Hemel Hempstead
    5
    Herts
    England
    EnglandBritishChartered Secretary15818320006
    BROWN, Jack Henry
    14 Bellrope Lane
    NR18 0QY Wymondham
    Norfolk
    Amministratore
    14 Bellrope Lane
    NR18 0QY Wymondham
    Norfolk
    BritishDirector31834290002
    CALLAGHAN, Peter William
    Emerys Bucks Lane
    Little Eversden
    CB3 7HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Emerys Bucks Lane
    Little Eversden
    CB3 7HL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector8093260001
    CRAMPHORN, Terence Henry
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    White Oaks Moor Hall Lane
    Danbury
    CM3 4ER Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishDirector47883780001
    CRAVEN, Timothy Asgill
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Moatfields
    Hoxne
    IP21 5AL Eye
    Suffolk
    BritishCompany Secretary20737780001
    DANNHAUSER, David Stephen
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    8 Marsworth Avenue
    HA5 4UB Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant55176170003
    FUGACCIA, Paul David
    5 Churchfields
    WA8 9RP Widnes
    Cheshire
    Amministratore
    5 Churchfields
    WA8 9RP Widnes
    Cheshire
    EnglandBritishTimber Frame Housing123876350001
    HADDON, Anthony
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    Amministratore
    Forest House
    Thornton Lane
    LE67 9RP Markfield
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager72194430001
    HAYWOOD, Mark Royston
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    8 Abinger Way
    Eaton
    NR4 6NA Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishAccountant68960560002
    HIGGINS, Geoffrey John
    Greentyles Common Road
    Bressingham
    IP22 2BB Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Greentyles Common Road
    Bressingham
    IP22 2BB Diss
    Norfolk
    BritishExecutive Chairman27573580001
    HOLMES, Granville
    46 Fraser Close
    NN11 5HD Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    46 Fraser Close
    NN11 5HD Daventry
    Northamptonshire
    BritishSales Director20737800001
    HOUSEMAN, Christopher
    5 Reeves Pightle
    Great Chishill
    SG8 8SL Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Reeves Pightle
    Great Chishill
    SG8 8SL Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector70735110001
    KETTELEY, John Henry Beevor
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    Amministratore
    Keeway
    Ferry Road, Creeksea
    CM0 8PL Burnham On Crouch
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director3514610001
    LOWE, David Howard
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Willowdale The Street
    Redgrave
    IP22 1RY Diss
    Norfolk
    EnglandBritishEngineer40112290001
    NEWBY, Frederick Edward
    Farthingham Lane Ocklet Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    Amministratore
    Farthingham Lane Ocklet Road
    Ewhurst
    GU6 7QN Cranleigh
    Hartley
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director28923840001
    PETERS, Christopher John
    The Manor House Manor Road
    Roydon
    IP22 3QS Diss
    Norfolk
    Amministratore
    The Manor House Manor Road
    Roydon
    IP22 3QS Diss
    Norfolk
    BritishManaging Director40040990002
    SHACKELL, Martin Edward
    9 Gilbey Close
    NN9 5YG Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    9 Gilbey Close
    NN9 5YG Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishGeneral Manager51840120001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    Amministratore
    Stannage Lane
    Churton
    CH3 6LE Chester
    Westleigh
    United KingdomBritishCompany Director37111560008
    TAYLOR, Paul James
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    40 Azalea Close
    LE17 4FR Lutterworth
    Leicestershire
    United KingdomBritishGeneral Manager69909170003
    TURNER, Matthew Lloyd
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    England
    Amministratore
    Clifton Street
    EC2A 4HB London
    66
    England
    EnglandBritishChartered Accountant158037130001
    WEBSTER, Michael John
    Coles Park House
    Cole Park Westmill
    SG9 9LT Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Coles Park House
    Cole Park Westmill
    SG9 9LT Buntingford
    Hertfordshire
    BritishDirector21651670001
    WHITE, David John
    14 Lovat Close
    IP20 9HJ Harlestone
    Norfolk
    Amministratore
    14 Lovat Close
    IP20 9HJ Harlestone
    Norfolk
    BritishGeneral Manager85510430001
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    17 Heron Close
    CM21 0BB Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Heron Close
    CM21 0BB Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishDirector22806550001

    YAXLEY SPP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH september 2007 and
    Creato il 05 gen 2009
    Consegnato il 14 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 12 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off dated 4 march 1999 and
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 26 mag 1999
    Consegnato il 02 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Eye airfield eye suffolk.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture deed
    Creato il 05 mar 1999
    Consegnato il 26 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 08 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 26 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 used no.2 Speedeck machine plus tooling serial no; 10006 and any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 10/2/93 issued by the company
    Creato il 21 nov 1996
    Consegnato il 04 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    All rights title and interest in or arising out of a factoring or invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 11/9/96; all book/other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 set 1996
    Consegnato il 14 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 14 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 1993
    Consegnato il 09 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at yaxley,eye,suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 feb 1993
    Consegnato il 22 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 M290C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 mar 1986
    Consegnato il 01 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Please see doc M22 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Australia and New Zealand Banking Group LTD
    Transazioni
    • 01 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1983
    Consegnato il 09 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the security documents d/d 13/10/80
    Brevi particolari
    Legal mortgage:- f/h land and comprising for parcels of land froming part of 0563 part 0564 part 0568 yaxley and part 05781 part 05782 note county of suffolk together with the buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • I.C.F.C. LTD
    Transazioni
    • 09 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1981
    Consegnato il 20 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H yaxley, eye, suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 13 ott 1980
    Consegnato il 16 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    57 burkitt road, corby, northants. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Icfc LTD
    Transazioni
    • 16 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    YAXLEY SPP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 nov 2015Conclusione della liquidazione
    17 apr 2014Data della petizione
    23 set 2020Data di scioglimento
    09 giu 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0