NETWORK DISTRIBUTING LIMITED

NETWORK DISTRIBUTING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNETWORK DISTRIBUTING LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01476436
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUND AND MEDIA LIMITED17 ago 199417 ago 1994
    SOUND SOLUTIONS LIMITED28 gen 199228 gen 1992
    MAINLINE RECTRACK LIMITED14 feb 198614 feb 1986
    MAINLINE RECORD COMPANY LIMITED 02 ago 198502 ago 1985
    MAINLINE RECORD CO. LIMITED31 gen 198031 gen 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 giu 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 giu 2024

    31 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Soddisfazione dell'onere 014764360009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 014764360010 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 20 Berghem Mews Blythe Road London W14 0HN England a 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 16 giu 2023

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    12 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 giu 2023

    LRESEX

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Juan Veloza Vargas come amministratore in data 25 gen 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tim Alan Beddows come amministratore in data 19 nov 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Jonathan Anthony James Lack come amministratore in data 23 mar 2022

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 014764360010, creata il 02 nov 2021

    24 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    12 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 014764360009, creata il 13 mar 2020

    55 pagineMR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Tim Alan Beddows il 30 giu 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LACK, Jonathan Anthony James
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    United KingdomBritishDirector142626960003
    VELOZA VARGAS, Juan
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    United KingdomBritish,ColombianDirector305274590001
    BAYLISS, Joshua
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    Segretario
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    British114409340001
    COLLINS, Peter Alan
    Hightrees
    8 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    Segretario
    Hightrees
    8 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    BritishRecord Dealer29565390004
    GERRARD, Barry Alexander Ralph
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Segretario
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    British188290005
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Segretario
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Segretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    ABBOTT, Trevor Michael
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director35278820001
    BEDDOWS, Tim Alan
    Berghem Mews
    Blythe Road
    W14 0HN London
    Unit 20
    England
    Amministratore
    Berghem Mews
    Blythe Road
    W14 0HN London
    Unit 20
    England
    EnglandBritishProducer97663340001
    COLLINS, Peter Alan
    24 The Riverside
    Graburn Way Hampton Court
    KT8 9BF East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    24 The Riverside
    Graburn Way Hampton Court
    KT8 9BF East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritishDirector29565390006
    DE ANTONI, Claudia
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    The Battleship Building
    United Kingdom
    Amministratore
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    The Battleship Building
    United Kingdom
    United KingdomItalianFinance Professional173947040001
    DEUGO, Hans De
    Tonannes
    Kortland 2a
    FOREIGN Lopik
    3412-Kw
    Holland
    Amministratore
    Tonannes
    Kortland 2a
    FOREIGN Lopik
    3412-Kw
    Holland
    DutchSalesman29565400001
    EMBLEY, Deborah Jayne
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    Amministratore
    Flat 1
    64 Cromwell Avenue Highgate
    N6 5HQ London
    EnglandBritishChartered Accountant75933680001
    FOYN, Philip Dennis
    Croydon Road
    CR3 6QD Caterham
    98
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Croydon Road
    CR3 6QD Caterham
    98
    Surrey
    United Kingdom
    BritishFinance Director133880950001
    GILBRIDE, Michael Bernard Jonathan
    18 Broughton Road
    Ealing
    W13 8QW London
    Amministratore
    18 Broughton Road
    Ealing
    W13 8QW London
    United KingdomBritishCompany Director32396280002
    HALL, Susannah Mary Louise
    76 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    Amministratore
    76 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    BritishDirector Of Financial Control75930520004
    HINDLE, Alun Timothy
    Dulwich Village
    SE21 7BU London
    9
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Dulwich Village
    SE21 7BU London
    9
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Manager122149060002
    JACKSON, John Ellis
    Avalon 26 Abbey Gardens
    Upper Woolhampton
    RG7 5TZ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Avalon 26 Abbey Gardens
    Upper Woolhampton
    RG7 5TZ Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director2219540003
    LEE, Andrew Shore
    Elmwood Avenue
    PO22 8DE Bognor Regis
    21
    West Sussex
    Amministratore
    Elmwood Avenue
    PO22 8DE Bognor Regis
    21
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant131320710001
    MAZOTTI, Gary Wheatley
    96 Cleveland Gardens
    SW13 0AH London
    Amministratore
    96 Cleveland Gardens
    SW13 0AH London
    BritishFinancial Director67852160002
    MITTRICH, Wilhelm
    Dorfstrasse 6
    Stohl D 2301
    Germany
    Amministratore
    Dorfstrasse 6
    Stohl D 2301
    Germany
    GermanDirector44229430001
    MOUGIN, Mathilde Louise Marie
    50 Brook Green
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Brook Green
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCorporate Finance Analyst151182340001
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Amministratore
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    BritishCompany Director70496800002
    RODIE, Kirsten Jane
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    United KingdomAustralianInvestment Analyst146547110001
    ROHNER, Werner
    Klusenstrasse 28
    Adligensnil Ch 6043
    Switzerland
    Amministratore
    Klusenstrasse 28
    Adligensnil Ch 6043
    Switzerland
    SwissDirector33567260001
    STENT, Carla Rosaline
    50 Brook Green
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Brook Green
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant152825570001
    WORSFOLD, Philip John Curtis
    8 Essenden Road
    Sanderstead
    CR2 0BU Croydon
    Surrey
    Amministratore
    8 Essenden Road
    Sanderstead
    CR2 0BU Croydon
    Surrey
    EnglandBritishDirector93496440001
    WORSFOLD, Robert William Curtis
    Copperfield
    2 Monahan Avenue
    CR8 3BA Purley
    Surrey
    Amministratore
    Copperfield
    2 Monahan Avenue
    CR8 3BA Purley
    Surrey
    United KingdomBritishOperations Director114584490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NETWORK DISTRIBUTING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Tim Alan Beddows
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    06 apr 2016
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NETWORK DISTRIBUTING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 nov 2021
    Consegnato il 03 nov 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including any land and buildings specified in section 3 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings; and. Ii) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company.".
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Time Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 03 nov 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 mar 2020
    Consegnato il 30 mar 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Reward Capital Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 ott 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17 feb 1998 and
    Creato il 01 set 2008
    Consegnato il 11 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 17 february 1998
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 10 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re sound and media limited and numbered 1420211 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 05 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 19TH june 1987 issued by the company
    Creato il 12 nov 1991
    Consegnato il 29 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a receivables financing agreement dated 10TH july 1986 between h & h factors limited and the company. See form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 giu 1987
    Consegnato il 26 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 lug 1986
    Consegnato il 12 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement or leasing agreement on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The ultimate balance due or owing to the company by h & h under any present or future factoring agreement (for full details see doc M23).
    Persone aventi diritto
    • H & H Factors Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 1984
    Consegnato il 08 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NETWORK DISTRIBUTING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 giu 2023Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Karr
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Jamie Taylor
    1066 London Road
    SS9 3NA Leigh On Sea
    Essex
    Praticante
    1066 London Road
    SS9 3NA Leigh On Sea
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0