GEOQUEST HOLDINGS LIMITED

GEOQUEST HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGEOQUEST HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01478324
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bishop Fleming
    16 Queen Square
    BS1 4NT Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ECL HOLDINGS LIMITED01 nov 199501 nov 1995
    INTERA INFORMATION TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED04 nov 199104 nov 1991
    E.C.L. HOLDINGS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    BALLHAND LIMITED11 feb 198011 feb 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    2 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Victory House Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9LU United Kingdom in data 06 feb 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 dic 2009

    LRESSP

    Cessazione della carica di Rebecca Martin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Goldby come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GEOQUEST HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DROY MOORE, Pauline
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    Segretario
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    British138236320002
    DROY MOORE, Pauline
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    Amministratore
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    EnglandBritish138236320002
    SMOKER, Simon
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    Amministratore
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    United KingdomBritish134158640001
    DAVISON, Douglas Stewart
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    Segretario
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    British38662990001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Segretario
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    British32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    ZIMMER, Harold Rudy
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Segretario
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Canadian44656690001
    BULLOCK, Brian Leonard
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Amministratore
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Canadian25257010001
    GOLDBY, Alan John
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    British7619430001
    HODGKINSON, David Percival, Dr
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish25256980001
    JACKMAN, Christopher Holgate
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British10419170001
    MARTIN, Rebecca Helen
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    Amministratore
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    United KingdomNew Zealander134158470001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Amministratore
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    EnglandBritish32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    SECRETI, Salvatore
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Amministratore
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Canadian46635930001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    WOODWARD, Robert Stephen
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    Amministratore
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    CanadaBritish30307660001

    GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 feb 1994
    Consegnato il 21 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee under the terms of the facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 21 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 29 ott 1985
    Consegnato il 31 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hongkong Bank Limited
    Transazioni
    • 31 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 02 mag 1985
    Consegnato il 22 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 30/11/84
    Brevi particolari
    Assignment by way of charge of all right, title & interest of the company in all the inventions represented by letters patent of the united kingdom etc (for full details see doc M36).
    Persone aventi diritto
    • Wardley London Limited
    Transazioni
    • 22 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set-off
    Creato il 19 ott 1984
    Consegnato il 02 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sums stading to the credit of any account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 mag 1983
    Consegnato il 11 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, all buildings fixtures plant & machinery all stocks shares & securities.
    Persone aventi diritto
    • T R Trustees Corporation PLC
    • T R North America Investments Turst PLC
    • Wardley Limited
    Transazioni
    • 11 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 09 mag 1983
    Consegnato il 11 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, all buildings fixtures. All plant & machinery all stocks shares & securities.
    Persone aventi diritto
    • Anthony Gibbs & Sons Limited
    Transazioni
    • 11 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 16 ago 1982
    Consegnato il 28 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery, all stocks, shares & other securities.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 dic 2009Inizio della liquidazione
    23 mar 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samuel Jonathan Talby
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath
    Praticante
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0