COWIE CONTRACT HIRE LIMITED

COWIE CONTRACT HIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOWIE CONTRACT HIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01481834
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EQUITYCR0WN LIMITED27 feb 198027 feb 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71
    A2613AKW

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 21 nov 2012

    2 pagineAD01
    A1LUPGT6

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    A1LUPGTU

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A1LUPGZ5

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 nov 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Martin James Hibbert come amministratore in data 23 ott 2012

    1 pagineTM01
    X1K48TGP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA
    A1FCWV9U

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03
    X19YBIOQ

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mag 2012

    Stato del capitale al 04 mag 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X188IDAI

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA
    AD3CIXAR

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01
    X2P0HVGG

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01
    X2OY4VG0

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    XICAUTUI

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 03 mag 2011

    2 pagineCH01
    XICATTUH

    Nomina di Mr Martin James Hibbert come amministratore

    2 pagineAP01
    XG5EYQP9

    Cessazione della carica di Stephen Lonsdale come amministratore

    1 pagineTM01
    XG5DXQP7

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA
    A9NSRNFR

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XTQWKJVA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010

    1 pagineCH03
    XTQWJJV9

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA
    AES1JACM

    legacy

    3 pagine363a
    XBATP9MV

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA
    ALR6V0VI

    legacy

    3 pagine363a
    X447705O

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COWIE CONTRACT HIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Amministratore
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Amministratore
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director142033700001
    HIBBERT, Martin James
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritishChartered Accountant111092090001
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishChartered Accountant1108360001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    PYKETT, Terrance Neil
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    Amministratore
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director8804520002
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001

    COWIE CONTRACT HIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 giu 1992
    Consegnato il 25 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the beneficiaries (as defined in the intercreditor deed dated 17/06/92) (the "security trustee") and/or to the beneficiaries under or pursuant to the relevant documents ( as defined) including this debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge over the land,special deposits,intellectual property,goodwill assigned to the security trustee the right,title and interest of the chargor to and in each of the property rights,insurance,debts,investments,uncalled capital. Floating charge over the whole of the chargor's undertaking and assets present and future see doc for details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co.Limited
    Transazioni
    • 25 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    On hiring agreements charge
    Creato il 28 giu 1990
    Consegnato il 03 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit and right to rents hire charges, agreements, and right, title and interest in respect of motor vehicles, proceeds of sale, monies and other debts (see see doc M294C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental guarantee & debenture
    Creato il 08 set 1989
    Consegnato il 13 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for itself and the banks as defined on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking and all property and assets of the company see doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent for Itself and the Bank as Defined
    Transazioni
    • 13 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 ago 1988
    Consegnato il 10 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent for the Banks Named on the Schedulefull Details)Attached to the Certificate (Please See Doc For
    Transazioni
    • 10 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A guarantee and debenture
    Creato il 15 mag 1987
    Consegnato il 21 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent on any account whatsoever under the terms of a guarantee and debenture dated 15/5/87
    Brevi particolari
    (See 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transazioni
    • 21 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Deed of accession & supplemental
    Creato il 12 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee for itself and as agent for the banks as defined supplemental to a guarantee & debenture dated 30.10.85
    Brevi particolari
    See doc for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank as Agent for the Banks as Listed in the Schedule
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 ott 1985
    Consegnato il 06 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 30TH oct 1985 and the deed of even date.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transazioni
    • 06 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 16 set 1985
    Consegnato il 26 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of all contracts for the hire of motor vehicles on conditional sale, lease on contract hire with the chargee & all rights & titles to the vehicles, proceeds of sale & any insurance monies receivable.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transazioni
    • 26 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 18 giu 1985
    Consegnato il 28 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all moneys due or to become due from broadwood finance company limited to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 28 giu 1985Registrazione di un'ipoteca

    COWIE CONTRACT HIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 lug 2013Data di scioglimento
    13 nov 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0