JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.

JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01492610
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    • Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    R I M LETTERBOX DIRECT LIMITED04 feb 199904 feb 1999
    D.D. DISTRIBUTION LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    FLAMENCO DEVELOPMENTS LIMITED22 apr 198022 apr 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    49 pagineAM23

    Indirizzo della sede legale modificato da Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 17 mar 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    55 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    5 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    57 pagineAM10

    Cessazione della carica di Peter Mccall come segretario in data 17 mag 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David John King come amministratore in data 17 mag 2019

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    5 pagineAM06

    Indirizzo della sede legale modificato da Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG England a Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB in data 10 dic 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    123 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    5 pagineAM01

    Bilancio redatto al 30 dic 2017

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore in data 05 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 02 gen 2016

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2016

    Stato del capitale al 06 mag 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Cessazione della carica di Alan Stephen Plews come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan Stephen Plews come amministratore in data 01 ago 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 26 Whitehall Road Leeds LS12 1BE a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG in data 04 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 03 gen 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 28 dic 2013

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Segretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    British72684940002
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Segretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146964050001
    MILNES, Ann
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    British59652640002
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Segretario
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    Amministratore
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    British81185280001
    BARRETT, John Andrew
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    5 Westwood Road
    HU17 8EN Beverley
    North Humberside
    British9295350001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Amministratore
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritish251394160001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Amministratore
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    LAVERICK, Susan Christine
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish99591930001
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    British7475760001
    MILNER, Janet Mary
    Virginia Cottage
    Bishop Monkton
    HG3 3RQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Virginia Cottage
    Bishop Monkton
    HG3 3RQ Harrogate
    North Yorkshire
    British9547100001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    OAKLEY, Christopher John
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    British68410390001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    PLEWS, Alan Stephen
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish27819010002
    PLEWS, Alan Stephen
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish27819010002
    PLEWS, Alan Stephen
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    44 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish27819010002
    RILEY, Mark Andrew
    3 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Syke Green
    Scarcroft
    LS14 3BS Leeds
    West Yorkshire
    British27806630002
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    British9253330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Johnston Publishing Limited
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    06 apr 2016
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione01919088
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 giu 2014
    Consegnato il 01 lug 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 01 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of accession
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 30 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 17 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC Capital Markets(As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 17 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 11 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs International (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 set 1982
    Consegnato il 06 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale there of fixed & floating charge undertaking and all propery and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 22 set 1982
    Consegnato il 29 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp International Bank Limited
    Transazioni
    • 29 set 1982Registrazione di un'ipoteca

    JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 ago 2020Fine dell'amministrazione
    17 nov 2018Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0