JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.
Panoramica
| Nome della società | JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01492610 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
- Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione
Dove si trova JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Indirizzo della sede legale | Ship Canal House 8th Floor 98 King Street M2 4WB Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| R I M LETTERBOX DIRECT LIMITED | 04 feb 1999 | 04 feb 1999 |
| D.D. DISTRIBUTION LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| FLAMENCO DEVELOPMENTS LIMITED | 22 apr 1980 | 22 apr 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione | 49 pagine | AM23 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 17 mar 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 55 pagine | AM10 | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 5 pagine | AM19 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 57 pagine | AM10 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Mccall come segretario in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John King come amministratore in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 5 pagine | AM06 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG England a Alixpartners Uk Llp the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB in data 10 dic 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 123 pagine | AM03 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 5 pagine | AM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2017 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore in data 05 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 gen 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Alan Stephen Plews come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Stephen Plews come amministratore in data 01 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 26 Whitehall Road Leeds LS12 1BE a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG in data 04 ago 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 gen 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 28 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| COOPER, Philip Richard | Segretario | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | 131295290001 | ||||||
| HILL, Robert Christopher | Segretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | 72684940002 | ||||||
| MCCALL, Peter | Segretario | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 146964050001 | |||||||
| MILNES, Ann | Segretario | 5 Dawsons Meadow Farsley LS28 5TU Pudsey West Yorkshire | British | 59652640002 | ||||||
| YEOMANS, Graham Arthur | Segretario | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
| AUCKLAND, Stephen Andrew | Amministratore | The Croft 12 Town End Lane HD8 0NA Lepton Huddersfield | British | 81185280001 | ||||||
| BARRETT, John Andrew | Amministratore | 5 Westwood Road HU17 8EN Beverley North Humberside | British | 9295350001 | ||||||
| BOWDLER, Timothy John | Amministratore | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37521870002 | |||||
| CAMMIADE, Danny | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | 251394160001 | |||||
| FRY, John Anthony | Amministratore | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | 136914890001 | |||||
| HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 164400440001 | |||||
| KING, David John | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 179020430001 | |||||
| LAVERICK, Susan Christine | Amministratore | Sycamore Cottage Park Lane, Emley HD8 9SS Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 99591930001 | |||||
| LAWLER, Thomas Philip | Amministratore | Glenlair Cottage 15 Nab Lane BD18 4EH Shipley West Yorkshire | British | 7475760001 | ||||||
| MILNER, Janet Mary | Amministratore | Virginia Cottage Bishop Monkton HG3 3RQ Harrogate North Yorkshire | British | 9547100001 | ||||||
| MURRAY, Grant | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | 159877110001 | |||||
| OAKLEY, Christopher John | Amministratore | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | 68410390001 | ||||||
| PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| PLEWS, Alan Stephen | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | England | British | 27819010002 | |||||
| PLEWS, Alan Stephen | Amministratore | 44 Syke Green Scarcroft LS14 3BS Leeds West Yorkshire | England | British | 27819010002 | |||||
| PLEWS, Alan Stephen | Amministratore | 44 Syke Green Scarcroft LS14 3BS Leeds West Yorkshire | England | British | 27819010002 | |||||
| RILEY, Mark Andrew | Amministratore | 3 Syke Green Scarcroft LS14 3BS Leeds West Yorkshire | British | 27806630002 | ||||||
| TOULMIN, George Michael | Amministratore | The West Wing Thorp Arch Hall LS23 7AW Wetherby West Yorkshire | British | 9253330001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD.?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnston Publishing Limited | 06 apr 2016 | Bourges Boulevard PE1 1NG Peterborough Unex House - Suite B Cambridgeshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 giu 2014 Consegnato il 01 lug 2014 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 25 set 2009 Consegnato il 30 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture | Creato il 04 mar 1999 Consegnato il 17 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture dated 27TH february 1998) (all as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 feb 1998 Consegnato il 11 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents (or any of them) (including under the debenture) (all as therein defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 22 set 1982 Consegnato il 06 ott 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale there of fixed & floating charge undertaking and all propery and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 set 1982 Consegnato il 29 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
JOHNSTON LETTERBOX DIRECT LTD. ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0