PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED

PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01494788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARK AVENUE PRODUCTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY31 dic 198031 dic 1980
    ENDOWN LIMITED01 mag 198001 mag 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Neil Garth Jones come amministratore in data 01 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY a 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN in data 04 ago 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2015

    Stato del capitale al 17 ago 2015

    • Capitale: GBP 50,120
    SH01

    Nomina di Mrs Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alison Jane Clarke come amministratore in data 14 giu 2015

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD a 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY in data 03 lug 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Ms Alison Jane Clarke come amministratore in data 31 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sally-Ann Patricia Withey come amministratore in data 30 dic 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Jennifer Kathryn Lees come segretario in data 08 ago 2014

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2014

    Stato del capitale al 07 lug 2014

    • Capitale: GBP 50,120
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritish204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritish167225950001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Segretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    BUTTERWORTH, Tina Gillian
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    Segretario
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    British31799060001
    HARIA, Jigna
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    Segretario
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    British24063500003
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    British54128690001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritish39245820011
    ATTERBURY THOMAS, David
    47 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JW London
    Amministratore
    47 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JW London
    EnglandBritish38008820001
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Amministratore
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritish105342600002
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Amministratore
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritish76600500002
    BUTTERWORTH, Tina Gillian
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    Amministratore
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    British31799060001
    CADMAN, Anthony
    23 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Amministratore
    23 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British26272690001
    CARSWELL, Hugh Aidan
    Top Flat
    39 Beresford Road
    N5 2HS London
    Amministratore
    Top Flat
    39 Beresford Road
    N5 2HS London
    United KingdomBritish46017340001
    CLARKE, Alison Jane
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    Amministratore
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    United KingdomBritish93418210001
    DAWSON, Paul Timothy
    28 Greenlands Road
    TW18 4LR Staines
    Middlesex
    Amministratore
    28 Greenlands Road
    TW18 4LR Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish182444600001
    GREEN, Graham James
    Kings Mill House
    South Nutfield
    RH1 5NG Redhill
    Surrey
    Amministratore
    Kings Mill House
    South Nutfield
    RH1 5NG Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish10528660001
    GREENING, Nigel Douglas
    Smallbrook Barn
    Thursley
    GU8 6QN Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Smallbrook Barn
    Thursley
    GU8 6QN Godalming
    Surrey
    British64673590001
    HARIA, Jigna
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    British24063500003
    HORNE, Rebecca Adele
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritish188956200001
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish54128690003
    PEPLOW, Henry
    The Barn
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Barn
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish101890460001
    PERRY, Ian
    15 Lion Gate Gardens
    TW9 2DW Richmond
    Surrey
    Amministratore
    15 Lion Gate Gardens
    TW9 2DW Richmond
    Surrey
    British66616730001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritish10691510002
    TAPPING, Simon Mark
    43 Archway Street
    Barnes
    SW13 0AS London
    Amministratore
    43 Archway Street
    Barnes
    SW13 0AS London
    British47935050001
    TUKE-HASTINGS, Derrick Somerville
    Perrotts Brook House
    Perrotts Brook
    GL7 7BS Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Perrotts Brook House
    Perrotts Brook
    GL7 7BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish31799070001
    WEST, Paul William
    The Barton
    Neopardy
    EX17 5EP Crediton
    Devon
    Amministratore
    The Barton
    Neopardy
    EX17 5EP Crediton
    Devon
    British109447350002
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritish109428260052
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    British14119160001
    WROE, Denise
    3 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill Village
    NW7 1QY London
    Amministratore
    3 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill Village
    NW7 1QY London
    British80857550001
    YARDLEY, Daniel John
    Dingwall Road
    Earlsfield
    SW18 3AZ London
    21a
    Amministratore
    Dingwall Road
    Earlsfield
    SW18 3AZ London
    21a
    United KingdomBritish147796180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    I G Communications Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06 apr 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    No
    Forma giuridicaLimitedlliability Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2005521
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 12 ago 2005
    Consegnato il 26 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 ott 1987
    Consegnato il 22 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 mar 1986
    Consegnato il 26 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 16 mar 1981
    Consegnato il 30 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Sports Sponsorship International LTD
    Transazioni
    • 30 mar 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0