DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED

DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIALOGUE SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01495874
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
    • servizi di prestampa e pre-media (18130) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dst House
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOWITT DIGITAL LIMITED21 set 200521 set 2005
    EDEN LITHO REPRODUCTION LIMITED 08 mag 198008 mag 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    16 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 02 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2014

    • Capitale: GBP 101
    4 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    18 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Nomina di Gregg Givens come amministratore in data 05 ago 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Robert Evans come segretario in data 05 ago 2011

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Scott Taylor come segretario in data 05 ago 2011

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Nicolas William Dixon come amministratore in data 05 ago 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Scott Taylor come amministratore in data 05 ago 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Walters come amministratore in data 05 ago 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jason Charles Edward Cromack come amministratore in data 05 ago 2011

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVANS, Robert
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    United Kingdom
    British162765570001
    GIVENS, Gregg
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmericanAccountant99710370001
    BRIDGER, Brenda Phyllis
    17 Brian Crescent
    Southborough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    17 Brian Crescent
    Southborough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    British24031620001
    TAYLOR, Richard Scott
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    Segretario
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    BritishFinance Director35333200002
    BAILEY, Andrew
    26 Greenleas
    Pembury
    TN2 4NS Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    26 Greenleas
    Pembury
    TN2 4NS Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector122068360001
    BARTHOLOMEW, David
    Lower Birchetts
    Stockland Green Road
    TN3 0TY Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Lower Birchetts
    Stockland Green Road
    TN3 0TY Tunbridge Wells
    Kent
    BritishSystems Analyst51677470001
    BRIDGER, Brenda Phyllis
    17 Brian Crescent
    Southborough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    17 Brian Crescent
    Southborough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Secretary24031620001
    BRIDGER, Paul Bruce
    17 Brian Crescent
    South Borough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    17 Brian Crescent
    South Borough
    TN4 0AP Tunbridge Wells
    Kent
    BritishLithographer34639240001
    CROMACK, Jason Charles Edward
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    Amministratore
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    EnglandBritishDirector148492510001
    DIXON, Nicolas William
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    Amministratore
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    United KingdomBritishDirector24161370007
    MALLINSON, Christopher Kim
    Fir Trees
    Rannoch Road
    TN6 1RB Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Fir Trees
    Rannoch Road
    TN6 1RB Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritishLitho Grapher63067270002
    TAYLOR, Richard Scott
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    Amministratore
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    EnglandBritishFinance Directoer35333200003
    WALTERS, Jeremy Edward Charles
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    Amministratore
    St Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director234484880001

    DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 04 nov 2009
    Consegnato il 11 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 11 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 apr 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 lug 2007
    Consegnato il 21 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland Trading as Enterprise Finance Europe
    Transazioni
    • 21 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2003
    Consegnato il 12 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 13 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Xeicon printstreamer 2 for dcp/500 s/n 2084.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 13 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 31 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 31 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 apr 1990
    Consegnato il 23 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable propety & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0