DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01495874 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
- servizi di prestampa e pre-media (18130) / Industrie manifatturiere
Dove si trova DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Dst House St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HOWITT DIGITAL LIMITED | 21 set 2005 | 21 set 2005 |
EDEN LITHO REPRODUCTION LIMITED | 08 mag 1980 | 08 mag 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 02 set 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2014
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Gregg Givens come amministratore in data 05 ago 2011 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Robert Evans come segretario in data 05 ago 2011 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Scott Taylor come segretario in data 05 ago 2011 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicolas William Dixon come amministratore in data 05 ago 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Scott Taylor come amministratore in data 05 ago 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Walters come amministratore in data 05 ago 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason Charles Edward Cromack come amministratore in data 05 ago 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVANS, Robert | Segretario | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey United Kingdom | British | 162765570001 | ||||||
GIVENS, Gregg | Amministratore | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey United Kingdom | United States | American | Accountant | 99710370001 | ||||
BRIDGER, Brenda Phyllis | Segretario | 17 Brian Crescent Southborough TN4 0AP Tunbridge Wells Kent | British | 24031620001 | ||||||
TAYLOR, Richard Scott | Segretario | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey | British | Finance Director | 35333200002 | |||||
BAILEY, Andrew | Amministratore | 26 Greenleas Pembury TN2 4NS Tunbridge Wells Kent | British | Director | 122068360001 | |||||
BARTHOLOMEW, David | Amministratore | Lower Birchetts Stockland Green Road TN3 0TY Tunbridge Wells Kent | British | Systems Analyst | 51677470001 | |||||
BRIDGER, Brenda Phyllis | Amministratore | 17 Brian Crescent Southborough TN4 0AP Tunbridge Wells Kent | British | Company Secretary | 24031620001 | |||||
BRIDGER, Paul Bruce | Amministratore | 17 Brian Crescent South Borough TN4 0AP Tunbridge Wells Kent | British | Lithographer | 34639240001 | |||||
CROMACK, Jason Charles Edward | Amministratore | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey | England | British | Director | 148492510001 | ||||
DIXON, Nicolas William | Amministratore | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey | United Kingdom | British | Director | 24161370007 | ||||
MALLINSON, Christopher Kim | Amministratore | Fir Trees Rannoch Road TN6 1RB Crowborough East Sussex | United Kingdom | British | Litho Grapher | 63067270002 | ||||
TAYLOR, Richard Scott | Amministratore | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey | England | British | Finance Directoer | 35333200003 | ||||
WALTERS, Jeremy Edward Charles | Amministratore | St Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House Surrey | England | British | Managing Director | 234484880001 |
DIALOGUE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Creato il 04 nov 2009 Consegnato il 11 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 apr 2008 Consegnato il 09 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 20 lug 2007 Consegnato il 21 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 dic 2003 Consegnato il 12 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 11 lug 2000 Consegnato il 13 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Xeicon printstreamer 2 for dcp/500 s/n 2084. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
General charge | Creato il 30 ott 1992 Consegnato il 31 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 apr 1990 Consegnato il 23 apr 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including heritable propety & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0